HB (WM) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHB (WM) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03379746
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HB (WM) LIMITED?

    • Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra HB (WM) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HB (WM) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REDROW HOMES (WEST MIDLANDS) LIMITED02 ene 200102 ene 2001
    HARWOOD HOMES (MIDLANDS) LIMITED16 jun 199716 jun 1997
    ORCATEC LIMITED02 jun 199702 jun 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HB (WM) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2025
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HB (WM) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta02 jun 2026
    Próxima declaración de confirmación vence16 jun 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta02 jun 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HB (WM) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Michael Ian Scott como director el 13 nov 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Ian Scott como director el 21 ago 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Barbara Mary Richmond como director el 21 ago 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Helen Davies como director el 31 jul 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Timothy Huw Stone como director el 31 jul 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Barratt Corporate Secretarial Services Limited como secretario el 01 ago 2025

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Bethany Ford como secretario el 31 jul 2025

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Bethany Ford como secretario el 30 nov 2023

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Graham Anthony Cope como secretario el 30 nov 2023

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    2 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de HB (WM) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARRATT CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Cartwright Way
    Forest Business Park Bardon Hill
    LE67 1UF Coalville
    Barratt House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Cartwright Way
    Forest Business Park Bardon Hill
    LE67 1UF Coalville
    Barratt House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro05698395
    160289260001
    STONE, Timothy Huw
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Redrow House
    United Kingdom
    United Kingdom
    Director
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Redrow House
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish297709310001
    COPE, Graham Anthony
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Secretario
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    British85842880003
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secretario designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FORD, Bethany
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Secretario
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    316534490001
    WALKER, Rhiannon Ellis
    Gatesheath Hall
    Gatesheath Tattenhall
    CH3 9AH Chester
    Cheshire
    Secretario
    Gatesheath Hall
    Gatesheath Tattenhall
    CH3 9AH Chester
    Cheshire
    British86070003
    ANDROLIA, Linda Christine
    The Cottage 3 Church Lane
    Oddingley
    WR9 7NE Droitwich
    Worcestershire
    Director
    The Cottage 3 Church Lane
    Oddingley
    WR9 7NE Droitwich
    Worcestershire
    British100742160001
    BARTON, Alan John
    Church Cottage
    Stable Lane
    CW6 0JL Cotebrook
    Cheshire
    Director
    Church Cottage
    Stable Lane
    CW6 0JL Cotebrook
    Cheshire
    United KingdomBritish35780010001
    BOX, William
    Meadowcrest
    Coopers Hill
    B48 7BX Alvechurch
    Worcester
    Director
    Meadowcrest
    Coopers Hill
    B48 7BX Alvechurch
    Worcester
    British16898020002
    BRAND, William John
    Northfield House
    Dunt Lane
    RG10 0TA Hurst
    Berkshire
    Director
    Northfield House
    Dunt Lane
    RG10 0TA Hurst
    Berkshire
    EnglandBritish5202410003
    BRIGGS, Robert
    Stair Bridge House
    Victoria Street
    DE13 8NG Yoxall
    Staffordshire
    Director
    Stair Bridge House
    Victoria Street
    DE13 8NG Yoxall
    Staffordshire
    British87734330001
    BURY, Michael
    16 Moorlane
    Bolehall
    B77 3LJ Tamworth
    Staffordshire
    Director
    16 Moorlane
    Bolehall
    B77 3LJ Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritish87734280001
    CAFFERY, Hugh
    26 Blounts Drive
    ST14 8TQ Uttoxeter
    Staffordshire
    Director
    26 Blounts Drive
    ST14 8TQ Uttoxeter
    Staffordshire
    United KingdomBritish155150440001
    CAMPBELL KELLY, David John
    Bridgemere House
    Yew Tree Close
    LE8 6BU Willoughby Waterleys
    Leicestershire
    Director
    Bridgemere House
    Yew Tree Close
    LE8 6BU Willoughby Waterleys
    Leicestershire
    British40876330001
    COOPER, Jason Craig
    48 Lakeside Road
    Hill Top
    B70 0PW West Bromwich
    West Midlands
    Director
    48 Lakeside Road
    Hill Top
    B70 0PW West Bromwich
    West Midlands
    British73552570001
    CREE, George
    5 Bramber Way
    Norton
    DY8 2BQ Stourbridge
    West Midlands
    Director
    5 Bramber Way
    Norton
    DY8 2BQ Stourbridge
    West Midlands
    British85551180001
    DAVIES, Helen
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Director
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    United KingdomBritish83638070001
    DEW, Beverley Edward John
    Apartment 10
    41 Upper Belgrave Road Clifton
    BS8 2XH Bristol
    Avon
    Director
    Apartment 10
    41 Upper Belgrave Road Clifton
    BS8 2XH Bristol
    Avon
    British69504710002
    DORN, Alan John
    Stinchcombe
    3 Rosewood Way
    LE11 2BA Loughborough
    Leicestershire
    Director
    Stinchcombe
    3 Rosewood Way
    LE11 2BA Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish116992820001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Director designado
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Director designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    DWYER, Tom
    Mill House
    Bangley Lane
    B78 3EA Hints
    Tamworth
    Director
    Mill House
    Bangley Lane
    B78 3EA Hints
    Tamworth
    British77288920001
    FARR, Adrian Roy
    The Hawthorns
    24 Oak Tree Drive
    WR9 0QY Cutnall Green
    Worcestershire
    Director
    The Hawthorns
    24 Oak Tree Drive
    WR9 0QY Cutnall Green
    Worcestershire
    EnglandBritish86441760001
    FITZSIMMONS, Neil
    25 Cleveland Drive
    Little Sutton
    CH66 4XY South Wirral
    Director
    25 Cleveland Drive
    Little Sutton
    CH66 4XY South Wirral
    British69006050001
    GRUNDY, Andrew James
    2 Larch Rise
    The Lanes Leckhampton
    GL53 0PY Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    2 Larch Rise
    The Lanes Leckhampton
    GL53 0PY Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish78328160001
    HERRING, Elizabeth Anne
    Copley Lodge
    Copley Lane
    WV6 7DZ Pattingham
    Staffordshire
    Director
    Copley Lodge
    Copley Lane
    WV6 7DZ Pattingham
    Staffordshire
    British81615440001
    HOOTON, Philip Douglas
    25 Tideswell Close
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    Director
    25 Tideswell Close
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish122619590001
    LEWIS, Colin Edward
    Pantygoida Farm Talycoed Lane
    Llantilio Crossenny
    NP7 8TH Abergavenny
    Monmouthshire
    Director
    Pantygoida Farm Talycoed Lane
    Llantilio Crossenny
    NP7 8TH Abergavenny
    Monmouthshire
    WalesWelsh59395180001
    MICKLEWRIGHT, Graham
    75 Rugeley Road
    WS7 9BW Burntwood
    Staffordshire
    Director
    75 Rugeley Road
    WS7 9BW Burntwood
    Staffordshire
    United KingdomBritish98783370001
    PEDLEY, Paul Louis
    Tudor Lodge
    Briardale Road, Willaston
    CH64 1TD Neston
    Director
    Tudor Lodge
    Briardale Road, Willaston
    CH64 1TD Neston
    United KingdomBritish19874580001
    PRATT, Matthew John
    2 Tuckwood Court Wysall
    NG12 5PP Nottingham
    Plum Tree House
    Nottinghamshire
    Director
    2 Tuckwood Court Wysall
    NG12 5PP Nottingham
    Plum Tree House
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish125908560002
    RICHMOND, Barbara Mary
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    Director
    Redrow House
    St David's Park
    CH5 3RX Flintshire
    United KingdomBritish152559820001
    SCOTT, Michael Ian
    Cartwright Way
    Forest Business Park Bardon Hill
    LE67 1UF Coalville
    Barratt House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Cartwright Way
    Forest Business Park Bardon Hill
    LE67 1UF Coalville
    Barratt House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish290228130001
    THOMAS, David Wynne Bowen
    30 Chelveston Crescent
    B91 3YB Solihull
    West Midlands
    Director
    30 Chelveston Crescent
    B91 3YB Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish64895210001
    TURNBULL, Pauline Anne
    St. Leonards Street
    Mundford
    IP26 5DW Thetford
    29
    Norfolk
    United Kingdom
    Director
    St. Leonards Street
    Mundford
    IP26 5DW Thetford
    29
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandBritish137239850001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HB (WM) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Redrow Homes Limited
    St. Davids Park
    CH5 3RX Ewloe
    Redrow House
    Flintshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    St. Davids Park
    CH5 3RX Ewloe
    Redrow House
    Flintshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro1990710
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0