HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD
Visión general
Nombre de la empresa | HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD |
---|---|
Estado de la empresa | Liquidación |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03384947 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
Dirección de la sede social | James Watson House Rosehill Industrial Estate CA1 2UU Carlisle Cumbria |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
HAWK FACILITIES LIMITED | 29 sept 1998 | 29 sept 1998 |
HAWK IMPROVEMENTS LIMITED | 11 jun 1997 | 11 jun 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2021 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2022 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2020 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
Vencido | Sí |
---|---|
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jun 2022 |
Próxima declaración de confirmación vence | 25 jun 2022 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jun 2021 |
Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 jun 2024 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Fairview House Victoria Place Carlisle Cumbria CA1 1HP a James Watson House Rosehill Industrial Estate Carlisle Cumbria CA1 2UU el 01 ago 2023 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 jun 2023 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||||||||||
Declaración de asuntos | 17 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Grange Aston Street Wem Shrewsbury SY4 5AY England a Fairview House Victoria Place Carlisle Cumbria CA1 1HP el 27 jun 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Gordon Longmore como director el 29 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Leslie Edwards como director el 29 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Charles Hawkins como director el 03 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Gordon Longmore como director el 04 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Janette Helen Hawkins como director el 03 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2020 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2020 au 30 jun 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2020 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Edward Ernest Hawkins como director el 15 may 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Charles Hawkins como director el 12 may 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||
Notification de Anona Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 feb 2020 | 4 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Arthur Nixon como director el 13 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Arthur Nixon como secretario el 13 feb 2020 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Cessation de Janette Helen Hawkins en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 feb 2020 | 3 páginas | PSC07 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTS BOWEN, Alice | Director | Rosehill Industrial Estate CA1 2UU Carlisle James Watson House Cumbria | England | British | General Manager | 261681070001 | ||||
HAWKINS, Janette Helen | Secretario | House Loppington SY4 5SR Shrewsbury Grange United Kingdom | 184209550001 | |||||||
HAWKINS, Janette Helen | Secretario | Grange House Loppington SY4 5SR Wem Shropshire | British | Director | 37309220001 | |||||
NIXON, Alan Arthur | Secretario | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | Director | 67543830004 | |||||
SMITH, Pauline Margaret | Secretario | 76 Highfields SY2 5PJ Shrewsbury Salop | British | 21598370001 | ||||||
ASHBURTON REGISTRARS LIMITED | Secretario designado corporativo | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014760001 | |||||||
DOWLE, Kevin Mark | Director | Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange England | United Kingdom | British | General Manager | 134841280002 | ||||
ECCLESTON, Brian | Director | Pine View 4 High Fawr Avenue SY11 1TB Oswestry Salop | British | Director | 22732390002 | |||||
EDWARDS, Matthew Leslie | Director | Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange England | United Kingdom | British | General Manager | 261680860001 | ||||
EVANS, Lloyd Douglas | Director | 3 Ashcroft WV16 5PG Bridgnorth Shropshire | United Kingdom | British | Director | 42763690002 | ||||
EVANS, Lloyd Douglas | Director | 3 Ashcroft WV16 5PG Bridgnorth Shropshire | United Kingdom | British | Finance Director | 42763690002 | ||||
HAWKINS, Christopher Charles | Director | Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange England | England | British | Self Employed | 142720590003 | ||||
HAWKINS, Janette Helen | Director | Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange England | England | British | Company Director | 221060710001 | ||||
HAWKINS, Janette Helen | Director | Grange House Loppington SY4 5SR Wem Shropshire | England | British | Director | 37309220001 | ||||
HAWKINS, Michael Edward Ernest | Director | Grange House Loppington SY4 5SR Wem Shropshire | United Kingdom | British | Director | 188706610001 | ||||
LONGMORE, Stephen Gordon | Director | Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange England | England | British | Director | 267855740001 | ||||
NIXON, Alan Arthur | Director | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British | Director | 67543830004 | ||||
REEVES, Ian | Director | 61 Bastion Road LL19 7ET Prestatyn Denbighshire | United Kingdom | British | General Manager | 83483060001 | ||||
AR NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014750001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anona Homes Limited | 13 feb 2020 | 2 Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange, 2 Shropshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mrs Janette Helen Hawkins | 06 abr 2016 | Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 02 jun 2017 Entregado el 04 jun 2017 | Pendiente | ||
Breve descripción A fixed and floating charge over all assets. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 21 mar 2017 Entregado el 31 mar 2017 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Freehold of plots 19, 20, 22, 23, 24, 27, 33, 34 and 35 grange farm, loppington, wem shropshire registered with title numbers SL128605 and SL222933. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 20 nov 2015 Entregado el 24 nov 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Freehold land being land fronting noneley road, loppington, shrewsbury SY4 5SR being part of land registered at the land registry under title number SL128605 which is comprised in a transfer dated 20 november 2015 and made between (1) @sipp (pension trustees) limited and @ssas (pension trustees) limited and (2) hawk developments (UK) LTD. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 19 sept 2014 Entregado el 23 sept 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción F/H land fronting noneley road, loppington, shrewsbury t/no SL128605. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 13 mar 2001 Entregado el 29 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 06 oct 1997 Entregado el 07 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0