HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD

HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03384947
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    • Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    Dirección de la sede social
    James Watson House
    Rosehill Industrial Estate
    CA1 2UU Carlisle
    Cumbria
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HAWK FACILITIES LIMITED29 sept 199829 sept 1998
    HAWK IMPROVEMENTS LIMITED11 jun 199711 jun 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2021
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2022
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2020

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta11 jun 2022
    Próxima declaración de confirmación vence25 jun 2022
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta11 jun 2021
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 jun 2024

    10 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Fairview House Victoria Place Carlisle Cumbria CA1 1HP a James Watson House Rosehill Industrial Estate Carlisle Cumbria CA1 2UU el 01 ago 2023

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 jun 2023

    11 páginasLIQ03

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Declaración de asuntos

    17 páginasLIQ02

    Domicilio social registrado cambiado de The Grange Aston Street Wem Shrewsbury SY4 5AY England a Fairview House Victoria Place Carlisle Cumbria CA1 1HP el 27 jun 2022

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 15 jun 2022

    LRESEX

    Cese del nombramiento de Stephen Gordon Longmore como director el 29 abr 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Matthew Leslie Edwards como director el 29 abr 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Charles Hawkins como director el 03 abr 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Gordon Longmore como director el 04 abr 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Janette Helen Hawkins como director el 03 abr 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2020

    11 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2020 au 30 jun 2020

    1 páginasAA01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 jun 2020 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael Edward Ernest Hawkins como director el 15 may 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher Charles Hawkins como director el 12 may 2020

    2 páginasAP01

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Notification de Anona Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 feb 2020

    4 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Alan Arthur Nixon como director el 13 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alan Arthur Nixon como secretario el 13 feb 2020

    2 páginasTM02

    Cessation de Janette Helen Hawkins en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 feb 2020

    3 páginasPSC07

    ¿Quiénes son los directivos de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROBERTS BOWEN, Alice
    Rosehill Industrial Estate
    CA1 2UU Carlisle
    James Watson House
    Cumbria
    Director
    Rosehill Industrial Estate
    CA1 2UU Carlisle
    James Watson House
    Cumbria
    EnglandBritishGeneral Manager261681070001
    HAWKINS, Janette Helen
    House
    Loppington
    SY4 5SR Shrewsbury
    Grange
    United Kingdom
    Secretario
    House
    Loppington
    SY4 5SR Shrewsbury
    Grange
    United Kingdom
    184209550001
    HAWKINS, Janette Helen
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Secretario
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    BritishDirector37309220001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Secretario
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    BritishDirector67543830004
    SMITH, Pauline Margaret
    76 Highfields
    SY2 5PJ Shrewsbury
    Salop
    Secretario
    76 Highfields
    SY2 5PJ Shrewsbury
    Salop
    British21598370001
    ASHBURTON REGISTRARS LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Secretario designado corporativo
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014760001
    DOWLE, Kevin Mark
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    Director
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    United KingdomBritishGeneral Manager134841280002
    ECCLESTON, Brian
    Pine View
    4 High Fawr Avenue
    SY11 1TB Oswestry
    Salop
    Director
    Pine View
    4 High Fawr Avenue
    SY11 1TB Oswestry
    Salop
    BritishDirector22732390002
    EDWARDS, Matthew Leslie
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    Director
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    United KingdomBritishGeneral Manager261680860001
    EVANS, Lloyd Douglas
    3 Ashcroft
    WV16 5PG Bridgnorth
    Shropshire
    Director
    3 Ashcroft
    WV16 5PG Bridgnorth
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector42763690002
    EVANS, Lloyd Douglas
    3 Ashcroft
    WV16 5PG Bridgnorth
    Shropshire
    Director
    3 Ashcroft
    WV16 5PG Bridgnorth
    Shropshire
    United KingdomBritishFinance Director42763690002
    HAWKINS, Christopher Charles
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    Director
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    EnglandBritishSelf Employed142720590003
    HAWKINS, Janette Helen
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    Director
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    EnglandBritishCompany Director221060710001
    HAWKINS, Janette Helen
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Director
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    EnglandBritishDirector37309220001
    HAWKINS, Michael Edward Ernest
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Director
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector188706610001
    LONGMORE, Stephen Gordon
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    Director
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    EnglandBritishDirector267855740001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Director
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector67543830004
    REEVES, Ian
    61 Bastion Road
    LL19 7ET Prestatyn
    Denbighshire
    Director
    61 Bastion Road
    LL19 7ET Prestatyn
    Denbighshire
    United KingdomBritishGeneral Manager83483060001
    AR NOMINEES LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Director designado corporativo
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014750001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    2 Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange, 2
    Shropshire
    England
    13 feb 2020
    2 Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange, 2
    Shropshire
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro12450935
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Mrs Janette Helen Hawkins
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    06 abr 2016
    Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    The Grange
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 02 jun 2017
    Entregado el 04 jun 2017
    Pendiente
    Breve descripción
    A fixed and floating charge over all assets.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jun 2017Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 21 mar 2017
    Entregado el 31 mar 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Freehold of plots 19, 20, 22, 23, 24, 27, 33, 34 and 35 grange farm, loppington, wem shropshire registered with title numbers SL128605 and SL222933.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Goldentree Financial Services PLC
    Transacciones
    • 31 mar 2017Registro de una carga (MR01)
    • 04 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 20 nov 2015
    Entregado el 24 nov 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Freehold land being land fronting noneley road, loppington, shrewsbury SY4 5SR being part of land registered at the land registry under title number SL128605 which is comprised in a transfer dated 20 november 2015 and made between (1) @sipp (pension trustees) limited and @ssas (pension trustees) limited and (2) hawk developments (UK) LTD.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Goldentree Financial Services PLC
    Transacciones
    • 24 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    • 13 dic 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 19 sept 2014
    Entregado el 23 sept 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    F/H land fronting noneley road, loppington, shrewsbury t/no SL128605.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lsc Finance LTD
    Transacciones
    • 23 sept 2014Registro de una carga (MR01)
    • 18 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 13 mar 2001
    Entregado el 29 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 04 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 06 oct 1997
    Entregado el 07 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Wales PLC
    Transacciones
    • 07 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene HAWK DEVELOPMENTS (UK) LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 jun 2022Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Daryl Warwick
    Armstrong Watson Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria
    Profesional
    Armstrong Watson Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria
    Michael Christian Kienlen
    Armstrong Watson
    Fairview House
    CA1 1HP Victoria Place
    Carlisle Cumbria
    Profesional
    Armstrong Watson
    Fairview House
    CA1 1HP Victoria Place
    Carlisle Cumbria

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0