PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03389615 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 88 Wood Street EC2V 7QF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TRIBECA PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED | 14 ene 2004 | 14 ene 2004 |
| FREEHOLD PORTFOLIOS CHANCERY NOMINEES LIMITED | 09 sept 1997 | 09 sept 1997 |
| FREEHOLD PORTFOLIOS NOMINEES LIMITED | 20 jun 1997 | 20 jun 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 23 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 19 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Bow Bells House 1 Bread Street London EC4M 9HH England a 88 Wood Street London EC2V 7QF el 05 sept 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Cameron Shaun Murray el 10 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Bow Bells House 1 Bread Street London EC4N 9HH United Kingdom a 1 Bow Bells House 1 Bread Street London EC4M 9HH el 03 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Bow Bells House 1 Bread Street London EC2N 1HZ a 1 Bow Bells House 1 Bread Street London EC4N 9HH el 03 abr 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
legacy | 8 páginas | RP04CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 10 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 8 páginas | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2015 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2014 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O, Scottish Widows Investment Partnership Scottish Widows Investment Partnership 33 Old Broad Street London EC2N 1HZ a Bow Bells House 1 Bread Street London EC2N 1HZ el 03 jun 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Aberdeen Asset Management Plc como secretario el 28 ene 2015 | 3 páginas | AP04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | Secretario corporativo | Queens Terrace AB10 1YG Aberdeen 10 |
| 818260001 | ||||||||||
| IRELAND, Nicholas James Patrick | Director | 27 Park Terrace FK8 2JS Stirling | Scotland | British | 37007730009 | |||||||||
| MURRAY, Cameron Shaun | Director | Wood Street EC2V 7QF London 88 | Scotland | British | 190158150001 | |||||||||
| SMITH, Kate Susan | Secretario | Drylawhill East Linton EH40 3AZ East Lothian 7 | Other | 132379630001 | ||||||||||
| BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 138-142 Holborn EC1N 2TH Holborn | 109947730001 | |||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| LINEOBTAIN LIMITED | Secretario corporativo | Mountcliff House 154 Brent Street NW4 2DR London | 87536870003 | |||||||||||
| PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED | Secretario corporativo | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 93189540002 | |||||||||||
| BRETT, John Michael | Director | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | Scotland | British | 93200700002 | |||||||||
| LILLINGTON, Peter Murray | Director | c/o C/O, Scottish Widows Investment Partnership Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 | Scotland | British | 82434250002 | |||||||||
| RITBLAT, James William Jeremy | Director | 24 St Petersburgh Place W2 4LB London | England | British | 38424950003 | |||||||||
| WAGMAN, Colin Barry | Director | North Lodge 25 Ringwood Avenue N2 9NT London | United Kingdom | British | 39329840001 | |||||||||
| BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED | Director corporativo | 138-142 Holborn EC1N 2TH Holborn | 109947730001 | |||||||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Director designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 | |||||||||||
| PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED | Director corporativo | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 93189540002 | |||||||||||
| PORTMAN ADMINISTRATION 2 LIMITED | Director corporativo | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 88224330004 | |||||||||||
| WGTC NOMINEES LIMITED | Director corporativo | 138-142 Holborn EC1N 2TH Holborn | 109947830001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Overseas Bank Nominees Limited | 06 abr 2016 | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| W G T C Nominees Limited | 06 abr 2016 | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 22 dic 2003 Entregado el 12 ene 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company formerly k/a freehold portfolios chancery nominees limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The f/h property k/a halsbury house, 35-38 chancery lane, london WC2 and the blue anchor public house, rolls passage, london EC4 t/n NGL354193 and the l/h property k/a the blue anchor public house, rolls passage, london EC4,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 jul 1999 Entregado el 20 jul 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies whatsoever due or to become due from each borrower (as defined) and fp financial to each finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 11 sept 1997 Entregado el 25 sept 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All the liabilities of freehold portfolios chancery limited to the chargee of any kind pursuant to a loan agreement dated 10TH september 1997 as amended from time to time and all expenses (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene PROPERTY CHANCERY (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0