BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)
Visión general
| Nombre de la empresa | BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND) |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 03395681 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
- Actividades de organizaciones profesionales de miembros (94120) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
| Dirección de la sede social | Impact Hub Euston Triton Square NW1 3DX London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 ene 2026 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 29 ene 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 ene 2025 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr Nicholas Charles Waring el 01 ene 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cessation de Rainatou Sow en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Nicholas Waring en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Kirsty Jane Smith en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Anushree Chirag Rao en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Stella Ama Sekyeraa Opoku-Owusu en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Kate Newman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Othman Salim Moqbel en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Jasmina Haynes en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Graham Gordon en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Jennifer Codman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Charlotte Beacon en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Shazia Nasreen Arshad en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Akeem Idowu Abu en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 43 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Regents Wharf 8 All Saints Street, London N1 9RL a Impact Hub Euston Triton Square London NW1 3DX el 03 sept 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Kirsty Jane Smith en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 mar 2025 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Kate Newman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 mar 2025 | 2 páginas | PSC04 | ||
Modification des détails de Shazia Nasreen Arshad en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 mar 2025 | 2 páginas | PSC04 | ||
Cambio de datos del director Kirsty Jane Smith el 10 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Catherine Lois Sayer como director el 19 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Kate Newman el 10 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Akeem Idowu Abu el 10 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cessation de Catherine Lois Sayer en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 nov 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cambio de datos del director Shazia Nasreen Arshad el 10 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENHILL, Romilly | Secretario | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | 325991130001 | |||||||
| ABU, Akeem Idowu | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 331748120002 | |||||
| ARSHAD, Shazia Nasreen | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 331748210002 | |||||
| BEACON, Charlotte | Director | The Chase BR1 3DF Bromley 46 England | England | British | 303207370002 | |||||
| CODMAN, Jennifer | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | United Kingdom | British | 293087430002 | |||||
| GORDON, Graham | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 271552110001 | |||||
| HAYNES, Jasmina | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | Croatian | 317001980001 | |||||
| MOQBEL, Othman Salim | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 220961150001 | |||||
| NEWMAN, Kate | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 331747950002 | |||||
| OPOKU-OWUSU, Stella | Director | Bethnal Green Road E1 6LA London Afford Rich Mix Building 35-47 Bethnal Green Road England | United Kingdom | British | 278523220002 | |||||
| RAO, Anushree Chirag | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 293087830001 | |||||
| SMITH, Kirsty Jane | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 176419790001 | |||||
| SOW, Rainatou | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | United Kingdom | British | 278523380001 | |||||
| WARING, Nicholas Charles | Director | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | England | British | 107341910001 | |||||
| BENNETT, Anthony Richard | Secretario | 48 Church Hill Walthamstow E17 9RY London | British | 43267940001 | ||||||
| BUTLER, Paul James | Secretario | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | 179133610001 | |||||||
| HARPER, Adrian | Secretario | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | 149194510001 | |||||||
| HURTLEY, Charles | Secretario | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | 200606740001 | |||||||
| MACKAY, Graham, Dr | Secretario | Regents Wharf All Saints Street N1 9RL London Society Building, 8 England | 202896550001 | |||||||
| PORTEOUS, Emma Jane | Secretario | Clarendon Road W11 2HR London 92a United Kingdom | British | 95997930004 | ||||||
| PORTEOUS, Emma Jane | Secretario | Southern Row W10 5AN London 44c United Kingdom | British | 95997930002 | ||||||
| QUALTROUGH, Katherine Una | Secretario | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | 288849050001 | |||||||
| ROSEVEARE, Nicholas William | Secretario | 75 Main Road Long Hanborough OX29 8JX Witney Oxfordshire | British | 107942300001 | ||||||
| SCHWARZ, Franziska | Secretario | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | 286189360001 | |||||||
| ABRAMS, Zoe | Director | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | England | British | 254895510002 | |||||
| ACHU, Kamala | Director | 240 Langham Road N15 3NP London | British | 53183310001 | ||||||
| ALI, Mohammed | Director | 23 Freemantle House Somerford Street E1 5DD London | British | 55358340001 | ||||||
| ALLEN, Christine | Director | Hoppers Road N21 3LN London 29 England | England | British | 175732310001 | |||||
| ALLUM, Clifford Geoffrey, Dr | Director | 17 Sycamore Road Bournville B30 2AA Birmingham | United Kingdom | British | 34499990006 | |||||
| ASHTON, Beverley | Director | 78 Forest Road BA11 2TQ Frome Somerset | British | 65953290001 | ||||||
| BAILEY, Michael Robin | Director | The Coach House Underhill Lane Clayton BN6 9PJ Hassocks West Sussex | British | 51615220006 | ||||||
| BARNETT, Patricia | Director | 6 Tremlett Grove N19 5JX London | England | British | 49626700001 | |||||
| BARRY, Ian Charles | Director | 7 Northmoor Road OX2 6UW Oxford Oxfordshire | England | British | 117814870001 | |||||
| BENNETT, Graham | Director | 137 Barclay Road E17 9JL London | United Kingdom | British | 99105100001 | |||||
| BORDEN, Jennifer Edith | Director | 35 Lower Marsh SE1 7RT London | British | 53499170003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Shazia Nasreen Arshad | 24 nov 2024 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Akeem Idowu Abu | 19 nov 2024 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Kate Newman | 19 nov 2024 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Kirsty Jane Smith | 18 nov 2024 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Graham Gordon | 23 nov 2023 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Jasmina Haynes | 23 nov 2023 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: Croatian País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Othman Salim Moqbel | 23 nov 2023 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Charlotte Beacon | 24 nov 2022 | The Chase BR1 3DF Bromley 46 England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Gregge Andrew Kamal Nath Madan | 24 nov 2022 | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Anushree Chirag Rao | 25 nov 2021 | Calico House SW11 3TN London Concern Worldwide Greater London United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Jennifer Codman | 23 nov 2021 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Kashif Shabir | 23 nov 2021 | Regents Wharf 8 All Saints Street, N1 9RL London | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Rainatou Sow | 19 nov 2020 | Howard Road CB5 8QP Cambridge 10 United Kingdom United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Stella Ama Sekyeraa Opoku-Owusu | 19 nov 2020 | Triton Square NW1 3DX London Impact Hub Euston England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Nicholas Waring | 19 nov 2020 | Guithavon Rise CM8 1HE Essex 8 United Kingdom United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Monowara Gani | 19 nov 2020 | Park Road LE11 2HD Loughborough 143 England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Catherine Lois Sayer | 01 dic 2019 | Kingsmead Painswick GL6 6US Stroud Hillbrow England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Laura Elizabeth Jump | 01 dic 2019 | Pepys Road SE14 5SG London 151b United Kingdom United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Marcus John Missen | 17 dic 2018 | Blackness Road TN6 2LD Crowborough Brenner United Kingdom United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Ms Zoe Abrams | 07 dic 2018 | Chadwick Road SE15 4RA London 20 England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 31 dic 2016 | 31 dic 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0