HORROCKS GROUP PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | HORROCKS GROUP PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | 03407256 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HORROCKS GROUP PLC?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HORROCKS GROUP PLC?
| Dirección de la sede social | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HORROCKS GROUP PLC?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LITEDOCK LIMITED | 23 jul 1997 | 23 jul 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HORROCKS GROUP PLC?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HORROCKS GROUP PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alan Hayward como director el 22 ene 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Spann como director el 22 ene 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 08 oct 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como director el 08 oct 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 nov 2012 au 31 dic 2012 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Spann el 29 ago 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Richard Varley como director el 31 may 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2011 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Alison Margaret Shepley el 20 feb 2012 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Mcdonough como director el 31 dic 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Partnership House City West Business Park Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE4 7DF el 10 ago 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Judd como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Francis Tapp como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Richard John Howson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HORROCKS GROUP PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEPLEY, Alison Margaret | Secretario | Swan Street TW7 6RN Isleworth White Lion Court Middlesex United Kingdom | 160699410001 | |||||||
| ADAM, Richard John | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| HAYWARD, Alan | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| EMAKPOR, Efetobor | Secretario | 31 Hillingdon Road Stretford M32 8PH Manchester | British | 43738530001 | ||||||
| HORROCKS, Edward John | Secretario | 4 Heythrop Drive CH60 1YQ Wirral Merseyside | British | 15600830002 | ||||||
| JUDD, Christopher | Secretario | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House | British | 69049410002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CRYER, Frank Mayo | Director | 61 Osmaston Road Prenton CH42 8LR Birkenhead Wirral | England | British | 9024920001 | |||||
| EMAKPOR, Efetobor | Director | 31 Hillingdon Road Stretford M32 8PH Manchester | British | 43738530001 | ||||||
| HOLLAND, Eric | Director | Rose Cottage Alderley Road Winnington CW8 4BS Northwich Cheshire | British | 15569920001 | ||||||
| HORROCKS, Colin | Director | Heather Cottage The Ridge Heswall L60 6SP Wirral Merseyside | British | 15600840002 | ||||||
| HORROCKS, Derek Ian | Director | Dorset House Latchfore Road Gayton CH60 3RW Wirral | England | British | 47819720005 | |||||
| HORROCKS, Edward | Director | River View Lillyfield CH60 8NT Wirral Merseyside | British | 70700420002 | ||||||
| HORROCKS, Edward John | Director | 4 Heythrop Drive CH60 1YQ Wirral Merseyside | British | 15600830002 | ||||||
| HORROCKS, Olive | Director | Riverview Lillyfield CH60 8NT Wirral Merseyside | British | 15569940003 | ||||||
| HOWSON, Richard John | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| MCDONOUGH, John | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| MCMAHON, Michael | Director | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House | United Kingdom | British | 112505130001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Director | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House | United Kingdom | British | 112704610001 | |||||
| SPANN, Neil | Director | Regent Farm Road Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | 154870250001 | |||||
| TAPP, Richard Francis | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 173852420001 | |||||
| VARLEY, Paul Richard | Director | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | 137984880002 | |||||
| WATKINS, Jonathan Paul | Director | 14 Melksham Close SK11 8NH Macclesfield Cheshire | British | 54315290002 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene HORROCKS GROUP PLC alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creado el 12 dic 2005 Entregado el 29 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 27 oct 2000 Entregado el 03 nov 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental deed between the company and chargee relating to a debenture dated 27TH october 2000 between the company and chargee | Creado el 27 oct 2000 Entregado el 03 nov 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge over all stock shares debentures bonds and other securities under the terms of the supplemental security deed.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0