REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED

REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03410223
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Central House
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REDSTONE MANAGED SOLUTIONS LIMITED07 nov 200707 nov 2007
    TOLERANT SYSTEMS LTD28 jul 199728 jul 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 09 dic 2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium account be cancelled 18/11/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Declaración de confirmación presentada el 04 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Dean Anthony Barber como director el 03 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Dean Anthony Barber el 02 sept 2019

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Dean Anthony Barber como director el 02 sept 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 06 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    7 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Peter Brotherton como secretario el 03 sept 2018

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Harneet Jagpal como secretario el 03 sept 2018

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 06 jul 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Notification de Redcentric Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mar 2018

    2 páginasPSC09

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Fraser St John Fisher como director el 20 oct 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 06 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Peter James Brotherton como director el 28 nov 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter Brotherton como secretario el 28 nov 2016

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JAGPAL, Harneet
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    250197100001
    BROTHERTON, Peter James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Director
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish116701310002
    BROTHERTON, Peter
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    222049800001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    210014220001
    CROFT, Estelle Louise
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    195008140001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Secretario
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    162493770001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    HWUVEL, Christopher Edward Francis Van Den
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Secretario
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British114731960001
    MYHILL, Paul Harvey
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Secretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    175307710001
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Secretario
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    149400410001
    STIGWOOD, Roland Francis Wayne
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    Secretario
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    British46778900001
    TUNSTALL, Nicholas Paul
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Secretario
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    British57548240002
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Director
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BARBER, Dean Anthony
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Director
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish230739040001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Director
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish163698620001
    FISHER, Fraser St John
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Director
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish201664700001
    HALLETT, Peter John
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Director
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    United KingdomBritish20621770002
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Director
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Director
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish100207880001
    STIGWOOD, Roland Francis Wayne
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    Director
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    British46778900001
    TUNSTALL, Lynn
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Director
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    EnglandBritish53939130002
    TUNSTALL, Nicholas Paul
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Director
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    United KingdomBritish57548240002
    WEAVER, Anthony Charles
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Director
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Director
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    EnglandBritish42686850001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Redcentric Holdings Limited
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006, United Kingdom
    Lugar de registroCompanies House, United Kingdom
    Número de registro08399756
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 jul 201606 jul 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 abr 2015
    Entregado el 08 abr 2015
    Pendiente
    Breve descripción
    Lease over first and second floor, griffin house, ludgate hill, birmingham.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 08 abr 2015Registro de una carga (MR01)
    • 03 oct 2016Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 05 dic 2013
    Entregado el 12 dic 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    • 02 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 08 abr 2013
    Entregado el 11 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2013Registro de una carga (MR01)
    • 19 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Group debenture
    Creado el 21 jun 2012
    Entregado el 29 jun 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jun 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 abr 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 oct 2006
    Entregado el 13 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 11 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 29 jul 2004
    Entregado el 05 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all specified debts and other debts. By way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cattles Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 05 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 03 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 ene 2000
    Entregado el 03 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 15 dic 1998
    Entregado el 19 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 25 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0