DIRECT AUTO FINANCE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DIRECT AUTO FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03412137 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Dirección de la sede social | No. 1 Godwin Street BD1 2SU Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 jul 2021
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neeraj Kapur como director el 01 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon George Thomas como director el 31 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Charles Fisher como director el 03 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Simon George Thomas como director el 03 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2018 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David George Whincup como secretario el 16 jul 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paula Watts como secretario el 31 mar 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Malcolm John Le May como director el 12 mar 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Stuart Crook como director el 21 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Paula Watts como secretario el 12 may 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Emma Gayle Versluys como secretario el 12 may 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHINCUP, David George | Secretario | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | 251097020001 | |||||||
| KAPUR, Neeraj | Director | No. 1 Godwin Street BD1 2SU Bradford Provident Financial Plc West Yorkshire United Kingdom | England | British | 268623050001 | |||||
| LE MAY, Malcolm John | Director | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 43422720003 | |||||
| MARSHALL SMITH, Rosamond Joy | Secretario | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 17986770001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Secretario | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| PRINCE, Joseph Michael | Secretario | Meadowside Piltdown TN22 3XD Uckfield East Sussex | British | 71867540001 | ||||||
| VERSLUYS, Emma Gayle | Secretario | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | British | 102724740003 | ||||||
| WATTS, Paula | Secretario | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | 232277170001 | |||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| COOPER, Julian Edward Peregrine | Director | 17b Sheridan Road Merton Park SW19 3HW London | United Kingdom | British | 91049680001 | |||||
| CROOK, Peter Stuart | Director | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 109187730001 | |||||
| DUNKLEY, Paul John | Director | The Barn House 8-10 North Street NN6 0DW Rothersthorpe Northants | British | 34398930001 | ||||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Director | 17 Holt Avenue Adel LS16 8DH Leeds West Yorkshire | British | 77093570001 | ||||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Director | 17 Holt Avenue Adel LS16 8DH Leeds West Yorkshire | British | 77093570001 | ||||||
| FISHER, Andrew Charles | Director | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 41331580002 | |||||
| GLEN, Robert John | Director | 5 High Meadows Firth Lane Wilsden BD15 0HN Bradford West Yorkshire | England | United Kingdom | 87214920001 | |||||
| HARRISON, Richard | Director | 97 Orchard Grove Chalfont St Peter SL9 9ET Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 100892740002 | ||||||
| JOHNSTONE, Christopher Charles | Director | Pine Lodge Castle Lane Ripponden HX6 4JZ Sowerby Bridge West Yorkshire | British | 53747580002 | ||||||
| LINDSEY, Ian Walter | Director | 3 Kinderscout HP3 8HW Leverstock Green Hertfordshire | United Kingdom | British | 85980860001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Director | Murrayfield 13 Windsor Road SL9 7NB Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MARSHALL SMITH, Rosamond Joy | Director | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 17986770001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Director | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| MEYRICK, Stephen John | Director | 16 Delanly Court Wimblehurst Road RG12 2DU Horsham West Sussex | British | 106205110001 | ||||||
| NEWBY, Anthony Charles | Director | Millhouse Church Road, Woolton L25 6DA Liverpool | British | 54172180002 | ||||||
| NEWBY, Anthony | Director | 51 Wheatcroft Road Allerton L18 9UF Liverpool | British | 54172180001 | ||||||
| NEWBY, Leonard John | Director | Scheveningen Huis Ashdown Road RH18 5BN Forest Row East Sussex | British | 55084420001 | ||||||
| NEWBY, Leonard John | Director | Scheveningen Huis Ashdown Road RH18 5BN Forest Row East Sussex | British | 55084420001 | ||||||
| PARSONAGE, Robert David | Director | Homeleigh 10 Chart Way RH2 0NZ Reigate Surrey | British | 108363060001 | ||||||
| PLOWMAN, Stephen Russell | Director | Drummers Yard Sproutes Lane, Coolham RH13 8QH Horsham West Sussex | England | British | 76672190002 | |||||
| PLOWMAN, Stephen Russell | Director | Drummers Yard Sproutes Lane, Coolham RH13 8QH Horsham West Sussex | England | British | 76672190002 | |||||
| PRINCE, Joseph Michael | Director | Keffolds 44 Tongdean Avenue BN3 6TN Hove East Sussex | British | 71867540003 | ||||||
| SHAW, Simon Andrew | Director | Horrocks Close BD20 8HQ Lothersdale North Yorkshire | Uk | British | 87062650001 | |||||
| THOMAS, Simon George | Director | Godwin Street BD1 2SU Bradford No. 1 West Yorkshire | England | British | 253188120001 | |||||
| THORNTON, John Rolfe | Director | Kirk Lea Main Street HG5 9LD Staveley North Yorkshire | United Kingdom | British | 147555560001 | |||||
| WEBSTER, James Maxwell | Director | 28d Cruden Street N1 8NH London | United Kingdom | British | 97036540001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DIRECT AUTO FINANCE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Financial Plc | 06 abr 2016 | Godwin Street BD1 2SU Bradford No 1 Godwin Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene DIRECT AUTO FINANCE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creado el 26 jul 1999 Entregado el 30 jul 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee on behalf of itself and the banks from time to time parties to the facility agreement under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company and on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 11 feb 1999 Entregado el 19 feb 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a leased dated 11 february 1999 | |
Breve descripción The initial deposit £27,500. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 16 dic 1997 Entregado el 30 dic 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined) and all monies due or to become due from the company and each other company to the chargee under or pursuant to the secured documents and by any other present or future subsidiary of the parent or of any company | |
Breve descripción K/A unit 2 monckton road industrial estate denby dale road, wakefield t/no: WYK592491 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 12 nov 1997 Entregado el 14 nov 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Breve descripción £48,468.75 and all interest credited to the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene DIRECT AUTO FINANCE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0