THE DEVON DAIRY LIMITED

THE DEVON DAIRY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE DEVON DAIRY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03414586
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE DEVON DAIRY LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Tern Valley Business Park Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PENINSULA MILK PROCESSORS LIMITED05 ago 199705 ago 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Ronald Thornton como director el 30 ago 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Steven Paul Hodkinson como director el 30 ago 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Major Singh Rana como director el 30 ago 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Lee Greenbury como director el 18 dic 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher Ronald Thornton como director el 13 nov 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Ronald Mcinnes como director el 01 oct 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Lee Greenbury como director el 12 jun 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ronald Klaas Otto Kers como director el 30 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Maureen Agnes Burnside como secretario el 31 may 2017

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ago 2015

    Estado de capital el 14 ago 2015

    • Capital: GBP 366,039
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HODKINSON, Steven Paul
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Director
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish217572630001
    RANA, Major Singh
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Director
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish165428070001
    BURNSIDE, Maureen Agnes
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Secretario
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    153975620001
    DAVIDSON, Allison Jane
    11 Teign Village Hennock
    Bovey Tracey
    TQ13 9QJ Newton Abbot
    Devon
    Secretario
    11 Teign Village Hennock
    Bovey Tracey
    TQ13 9QJ Newton Abbot
    Devon
    British84272680001
    KITTOW, Allison Jane
    11 Teign Village
    Hennock
    TQ13 9QJ Bovey Tracey
    Devon
    Secretario
    11 Teign Village
    Hennock
    TQ13 9QJ Bovey Tracey
    Devon
    British84082280001
    LAWRENCE, Geoffrey Owen
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    Secretario
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    British46842010001
    OPENSHAW, Sally Jane
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    Secretario
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    British54072560001
    REED, Lyndsay Anne
    19 Hawthorn Road
    Bishopsmead
    PL19 9DL Tavistock
    Devon
    Secretario
    19 Hawthorn Road
    Bishopsmead
    PL19 9DL Tavistock
    Devon
    British46842100001
    SWEENEY, Gerard
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    Secretario
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    British80242320001
    YOUNG, Karen Bridget
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    Secretario
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    British94953930001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Oceana House
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    Secretario corporativo
    Oceana House
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    59771390005
    BAKER, Peter Monty
    Three Oaks Gulworthy
    PL19 8AX Tavistock
    Devon
    Director
    Three Oaks Gulworthy
    PL19 8AX Tavistock
    Devon
    British43634310001
    BENNETT, Alan
    Pengelly
    Hewas Water
    PL26 7JG St Austell
    Cornwall
    Director
    Pengelly
    Hewas Water
    PL26 7JG St Austell
    Cornwall
    British71925150001
    BLADES, Laurence William
    Hurlditch Farm Lamerton
    PL19 8QA Tavistock
    Devon
    Director
    Hurlditch Farm Lamerton
    PL19 8QA Tavistock
    Devon
    British52674990001
    BURROW, Richard
    Rill Farm
    East Hill
    EX11 1QH Ottery St. Mary
    Devon
    Director
    Rill Farm
    East Hill
    EX11 1QH Ottery St. Mary
    Devon
    British71924930001
    DE BOER, Athe
    Lower Woodley
    PL30 5JN Bodmin
    Cornwall
    Director
    Lower Woodley
    PL30 5JN Bodmin
    Cornwall
    Dutch43634210001
    GREENBURY, Lee
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Director
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish61478920003
    KEANE, William Gerard
    33 Burnhead Road
    G43 2SU Glasgow
    Director
    33 Burnhead Road
    G43 2SU Glasgow
    ScotlandBritish33614620001
    KERS, Ronald Klaas Otto
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Director
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    EnglandDutch165776800001
    KIDSON, Graham Leonard Patrick
    Teign Gorge House
    Sandy Park, Chagford
    TQ13 8JW Newton Abbot
    Devon
    Director
    Teign Gorge House
    Sandy Park, Chagford
    TQ13 8JW Newton Abbot
    Devon
    British63723090002
    LAMDEN, David
    Antony Pedigree Farms
    West Antony
    PL11 3AB Torpoint
    Cornwall
    Director
    Antony Pedigree Farms
    West Antony
    PL11 3AB Torpoint
    Cornwall
    British54820180002
    LAWRENCE, Geoffrey Owen
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    Director
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    British46842010001
    LOUD, Sandra Gladys
    Northdown
    Lewdown
    EX20 4EB Okehampton
    Devon
    Director
    Northdown
    Lewdown
    EX20 4EB Okehampton
    Devon
    British54819870001
    MCINNES, Andrew Ronald
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Director
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    ScotlandBritish174315690001
    NICHOLLS, Barry John Leonard
    Stocks Farm House
    The Stocks, Seend
    SN12 6PL Melksham
    Wiltshire
    Director
    Stocks Farm House
    The Stocks, Seend
    SN12 6PL Melksham
    Wiltshire
    EnglandBritish71018890006
    OPENSHAW, Nicholas Henry Folliott
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    Director
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    United KingdomBritish44347590002
    OVENS, Jeremy
    Brendon Farm
    Halwill
    EX21 5UH Beaworthy
    Devon
    Director
    Brendon Farm
    Halwill
    EX21 5UH Beaworthy
    Devon
    British65850270001
    PARISH, David Edmund
    Weir Mill Farm
    Willand
    EX15 2RE Cullompton
    Devon
    England
    Director
    Weir Mill Farm
    Willand
    EX15 2RE Cullompton
    Devon
    England
    EnglandBritish34592070001
    POCOCK, Brian Walter
    Pennance Vean Farm
    Prosser Hill Gwithian
    TR27 5EB Hayle
    Cornwall
    Director
    Pennance Vean Farm
    Prosser Hill Gwithian
    TR27 5EB Hayle
    Cornwall
    EnglandBritish84082420001
    RICHARDS, David Maldwyn
    Ash Grove
    BA5 2LX Wells
    4
    Somerset
    United Kingdom
    Director
    Ash Grove
    BA5 2LX Wells
    4
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritish119384920003
    SWEENEY, Gerard
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    Director
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    United KingdomBritish80242320001
    THORNTON, Christopher Ronald
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Director
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish233720830001
    VENNING, Gerald William
    Lower Birch Farm
    Bere Alston
    PL20 7BY Yelverton
    Devon
    Director
    Lower Birch Farm
    Bere Alston
    PL20 7BY Yelverton
    Devon
    British43634420001
    WILLIAMS, David Anthony James
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    Director
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    EnglandBritish57267910003
    WISEMAN, Robert Tennant
    Auchterarder House
    PH3 1DZ Auchterarder
    Perthshire
    Director
    Auchterarder House
    PH3 1DZ Auchterarder
    Perthshire
    United KingdomBritish3813060003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THE DEVON DAIRY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Müller Wiseman Dairies Limited
    Glasgow Road
    East Kilbride
    G74 4PA Glasgow
    159
    Scotland
    06 abr 2016
    Glasgow Road
    East Kilbride
    G74 4PA Glasgow
    159
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCompany
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroScotland
    Número de registroSc146494
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene THE DEVON DAIRY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    An omnibus guarantee and set off agreement
    Creado el 20 feb 2006
    Entregado el 23 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 20 feb 2006
    Entregado el 23 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All plant and machinery vehicles computers and other equipment being two vertical stainless steel raw milk intake tanks capacity: 11,000 litres, two vertical jacketed raw milk intake tanks capacity: 45,000 litres and three vertical jacketed storage tanks capacity: 45,000 litres for details of further chattels charged please refer to form 395, and all spare parts replacements modifications and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 23 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 feb 2006
    Entregado el 23 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H properties k/a land being peninsula milk processing factory, hameldown road, okehampton t/n DN412666. Beardown road, exter road industrial estate, okehampton t/n DN480942 and l/h land being land at beardown road, exter road industrial estate, okehampton t/n DN480943, and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery, all moneys under contracts or policies of insurance relating to the property and the rents, profits, income fees and other sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 23 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 26 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    All assets debenture
    Creado el 20 feb 2006
    Entregado el 23 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 23 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 feb 2006
    Entregado el 23 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 15 oct 2004
    Entregado el 22 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of the chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Property k/a peninsula milk processing factory,hameldown road,okehampton,t/no's DN412666 and DN480942(f/h) and DN480943(l/h). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerleenbank B.a as Security Trustee
    Transacciones
    • 22 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 sept 2002
    Entregado el 05 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Capital Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 sept 2002
    Entregado el 02 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a peninsula milk processing factory, hameldown road, exeter, devon EX20 1UB t/no. DN412666 as continuing security for the payment of the mortgagee of all monies covenanted to be paid by the mortgagor and/or due to the mortgagee hereunder.
    Personas con derecho
    • Capital Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 sept 2002
    Entregado el 02 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 sept 2002
    Entregado el 02 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a peninsula milk processing facory, hameldown road, exeter, devon EX20 1UB. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 15 dic 1999
    Entregado el 24 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement dated (as therein defined) or otherwise
    Breve descripción
    Fixed charge all specified debts being any book debts (purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement) the ownership of which fail to vest in the chargee for any reason together with the related rights pertaining to such book debts, all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time owing to the company on any account whatsoever (together with the related rights) other than specified debts, floating charge such moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    Personas con derecho
    • First National Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 24 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 oct 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 mar 1999
    Entregado el 02 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land situate at the exeter road industrial estate okehampton in the county of devon.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed & floating charge
    Creado el 08 mar 1999
    Entregado el 10 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All debts and their related rights purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement which fail to vest absolutely and effectively in the security holder (for any reason) by way of floating charge all undertqaking and the property rights and assets of the company including stock in trade and uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 10 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 mar 1998
    Entregado el 27 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0