PREMIER INN MANCHESTER LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PREMIER INN MANCHESTER LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03416188 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
- Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Dirección de la sede social | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GOLDEN TULIP MANCHESTER LIMITED | 28 jul 2003 | 28 jul 2003 |
EXTRAMINI LIMITED | 07 ago 1997 | 07 ago 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 02 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 mar 2017 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Edward Jones como director el 26 ene 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Whitbread Secretaries Limited como secretario el 26 ene 2017 | 3 páginas | AP04 | ||||||||||
Nombramiento de Daren Clive Lowry como director el 26 ene 2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Whitbread Directors 2 Limited como director el 26 ene 2017 | 3 páginas | AP02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daren Clive Lowry como secretario el 26 ene 2017 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Whitbread Directors 1 Limited como director el 26 ene 2017 | 3 páginas | AP02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bhavesh Mistry como director el 26 ene 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 03 mar 2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Charles Flaum como director el 30 sept 2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Bhavesh Mistry el 12 dic 2014 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2016 con actualizaciones | 20 páginas | CS01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 26 feb 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Simon Edward Jones como director el 14 ago 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de John Joseph Forrest como director el 06 jul 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Paul Charles Flaum como director el 05 feb 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Patrick Joseph Anthony Dempsey como director el 05 feb 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 24 feb 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITBREAD SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court Bedfordshire |
| 197001710001 | ||||||||||
LOWRY, Daren Clive | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 87044470002 | ||||||||
WHITBREAD DIRECTORS 1 LIMITED | Director corporativo | Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court Bedfordshire |
| 164111250001 | ||||||||||
WHITBREAD DIRECTORS 2 LIMITED | Director corporativo | Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court Bedfordshire |
| 197001670001 | ||||||||||
LOWRY, Daren Clive | Secretario | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | British | 87044470002 | ||||||||||
METCALF, Nicola Jane | Secretario | Flat 1 25 Kings Road HG1 5JY Harrogate North Yorkshire | British | Pa | 73359340001 | |||||||||
PRATT, Emma Kate | Secretario | 9 Saint Andrews Gate Kirkby Malzeard HG4 3SP Ripon North Yorkshire | British | Secretary | 80731880001 | |||||||||
WISH, Emma Louise | Secretario | The Hutts Grewelthorpe HG4 3DA Ripon North Yorkshire | British | Secretary | 50991790002 | |||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | England | British | Managing Director | 100598030001 | ||||||||
DUKES, Paul | Director | 508 Gilbert House Barbican EC2Y 8BD London | British | Leisure Consultant | 76027630002 | |||||||||
ELLIOT, Colin David | Director | 54 Queens Grove NW8 6EN London | British | Company Director | 84492240002 | |||||||||
FLAUM, Paul Charles | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 97797290002 | ||||||||
FLAUM, Paul Charles | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 97797290002 | ||||||||
FORREST, John Joseph | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | England | British | Director | 204618050002 | ||||||||
GILL, David Alan | Director | Spindles St Marys Road Bowdon WA14 2PH Altrincham Cheshire | England | British | Financial Director | 37437870002 | ||||||||
GREEN, John Louis | Director | Hursley House The Warren, KT24 5RH East Horsley Surrey | England | British | Investment Management | 31444140002 | ||||||||
JONES, Simon Edward | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Managing Director Premier Inn Uk | 201568280001 | ||||||||
MISTRY, Bhavesh | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 139729660003 | ||||||||
PEARSON, Francis Nicholas Fraser, Sir | Director | 9 Upper Addison Gardens W14 8AL London | United Kingdom | British | Leisure Consultant | 18912510001 | ||||||||
PELLINGTON, Andrew David | Director | Whitbread Court Houghton Hall Business Park LU5 5XE Porz Avenue Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 191886610001 | ||||||||
ROBERTS, Peter William Denby | Director | The Hutts Hutts Lane, Grewelthorpe HG4 3DA Ripon | England | British | Leisure Consultant | 106538510001 | ||||||||
SCURRAH, Brian William | Director | Wet Earth Green Pendlebury M27 8AL Manchester 11 | England | British | Construction Manager | 126400930002 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Inn Manchester Holdings Limited | 06 abr 2016 | Porz Avenue LU5 5XE Dunstable Whitbread Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene PREMIER INN MANCHESTER LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 17 oct 2006 Entregado el 01 nov 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 31 mar 2006 Entregado el 11 abr 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Golden tulip hotel waters reach trafford park manchester t/no MAN44578. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Assignment of contracts by way of security | Creado el 10 abr 2002 Entregado el 17 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The company assigns to the bank absolutely and with full title guarantee; all the rights, titles, benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary, contractual or otherwise; all book and other debts, revenues and claims both present and future;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 14 nov 1997 Entregado el 20 nov 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All the property part title number GM610019 known as plot 1 wharfe side trafford park. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 oct 1997 Entregado el 18 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0