PREMIER INN MANCHESTER LIMITED

PREMIER INN MANCHESTER LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPREMIER INN MANCHESTER LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03416188
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GOLDEN TULIP MANCHESTER LIMITED 28 jul 200328 jul 2003
    EXTRAMINI LIMITED07 ago 199707 ago 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 mar 2017

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Simon Edward Jones como director el 26 ene 2017

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Whitbread Secretaries Limited como secretario el 26 ene 2017

    3 páginasAP04

    Nombramiento de Daren Clive Lowry como director el 26 ene 2017

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Whitbread Directors 2 Limited como director el 26 ene 2017

    3 páginasAP02

    Cese del nombramiento de Daren Clive Lowry como secretario el 26 ene 2017

    2 páginasTM02

    Nombramiento de Whitbread Directors 1 Limited como director el 26 ene 2017

    3 páginasAP02

    Cese del nombramiento de Bhavesh Mistry como director el 26 ene 2017

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 03 mar 2016

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Charles Flaum como director el 30 sept 2016

    2 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Bhavesh Mistry el 12 dic 2014

    3 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2016 con actualizaciones

    20 páginasCS01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 feb 2015

    12 páginasAA

    Nombramiento de Simon Edward Jones como director el 14 ago 2015

    3 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 02 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 ago 2015

    Estado de capital el 21 ago 2015

    • Capital: GBP 1,925,740
    SH01

    Cese del nombramiento de John Joseph Forrest como director el 06 jul 2015

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Paul Charles Flaum como director el 05 feb 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Patrick Joseph Anthony Dempsey como director el 05 feb 2015

    2 páginasTM01

    Estado de capital el 24 feb 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    ¿Quiénes son los directivos de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WHITBREAD SECRETARIES LIMITED
    Houghton Hall Business Park
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    Bedfordshire
    Secretario corporativo
    Houghton Hall Business Park
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    Bedfordshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro00204214
    197001710001
    LOWRY, Daren Clive
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary87044470002
    WHITBREAD DIRECTORS 1 LIMITED
    Houghton Hall Business Park
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    Bedfordshire
    Director corporativo
    Houghton Hall Business Park
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    Bedfordshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro278140
    164111250001
    WHITBREAD DIRECTORS 2 LIMITED
    Houghton Hall Business Park
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    Bedfordshire
    Director corporativo
    Houghton Hall Business Park
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    Bedfordshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro520719
    197001670001
    LOWRY, Daren Clive
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Secretario
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    British87044470002
    METCALF, Nicola Jane
    Flat 1
    25 Kings Road
    HG1 5JY Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    Flat 1
    25 Kings Road
    HG1 5JY Harrogate
    North Yorkshire
    BritishPa73359340001
    PRATT, Emma Kate
    9 Saint Andrews Gate
    Kirkby Malzeard
    HG4 3SP Ripon
    North Yorkshire
    Secretario
    9 Saint Andrews Gate
    Kirkby Malzeard
    HG4 3SP Ripon
    North Yorkshire
    BritishSecretary80731880001
    WISH, Emma Louise
    The Hutts Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    North Yorkshire
    Secretario
    The Hutts Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    North Yorkshire
    BritishSecretary50991790002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishManaging Director100598030001
    DUKES, Paul
    508 Gilbert House
    Barbican
    EC2Y 8BD London
    Director
    508 Gilbert House
    Barbican
    EC2Y 8BD London
    BritishLeisure Consultant76027630002
    ELLIOT, Colin David
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    Director
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    BritishCompany Director84492240002
    FLAUM, Paul Charles
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector97797290002
    FLAUM, Paul Charles
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritishChief Operating Officer97797290002
    FORREST, John Joseph
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector204618050002
    GILL, David Alan
    Spindles St Marys Road
    Bowdon
    WA14 2PH Altrincham
    Cheshire
    Director
    Spindles St Marys Road
    Bowdon
    WA14 2PH Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishFinancial Director37437870002
    GREEN, John Louis
    Hursley House
    The Warren,
    KT24 5RH East Horsley
    Surrey
    Director
    Hursley House
    The Warren,
    KT24 5RH East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishInvestment Management31444140002
    JONES, Simon Edward
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritishManaging Director Premier Inn Uk201568280001
    MISTRY, Bhavesh
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritishFinance Director139729660003
    PEARSON, Francis Nicholas Fraser, Sir
    9 Upper Addison Gardens
    W14 8AL London
    Director
    9 Upper Addison Gardens
    W14 8AL London
    United KingdomBritishLeisure Consultant18912510001
    PELLINGTON, Andrew David
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector191886610001
    ROBERTS, Peter William Denby
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    Director
    The Hutts
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    EnglandBritishLeisure Consultant106538510001
    SCURRAH, Brian William
    Wet Earth Green
    Pendlebury
    M27 8AL Manchester
    11
    Director
    Wet Earth Green
    Pendlebury
    M27 8AL Manchester
    11
    EnglandBritishConstruction Manager126400930002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PREMIER INN MANCHESTER LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Whitbread Court
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4553707
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene PREMIER INN MANCHESTER LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 17 oct 2006
    Entregado el 01 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 mar 2006
    Entregado el 11 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Golden tulip hotel waters reach trafford park manchester t/no MAN44578.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of contracts by way of security
    Creado el 10 abr 2002
    Entregado el 17 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The company assigns to the bank absolutely and with full title guarantee; all the rights, titles, benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary, contractual or otherwise; all book and other debts, revenues and claims both present and future;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 14 nov 1997
    Entregado el 20 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the property part title number GM610019 known as plot 1 wharfe side trafford park.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 20 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 oct 1997
    Entregado el 18 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 18 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0