BOS PERSONAL LENDING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BOS PERSONAL LENDING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03416733 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
| Dirección de la sede social | Trinity Road Halifax HX1 2RG |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRITANNIA PERSONAL LENDING LIMITED | 30 ene 1998 | 30 ene 1998 |
| NWS 325 LIMITED | 08 ago 1997 | 08 ago 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 04 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 18 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 04 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2025 | 10 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Praven Subbramoney como director el 17 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Hiral Gogoi como director el 18 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del secretario Alyson Elizabeth Mulholland el 12 may 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2023 au 30 jun 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 21 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Israel Santos Perez como director el 24 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Anish Bipin Ambani como director el 01 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Elyn Jane Corfield como director el 09 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Hiral Gogoi como director el 09 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 23 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Sara Jayne Bayley como director el 02 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 23 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Israel Santos Perez el 11 mar 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Elyn Jane Corfield como director el 09 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 1 páginas | AD02 | ||
¿Quiénes son los directivos de BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULHOLLAND, Alison Elizabeth | Secretario | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 238402550002 | |||||||
| AMBANI, Anish Bipin | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 306223830001 | |||||
| SUBBRAMONEY, Praven | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | South African | 337362030001 | |||||
| GITTINS, Paul | Secretario | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | 164928190001 | |||||||
| HENNESSEY, David Dermot | Secretario | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | 196033570001 | |||||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secretario | Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st Floor East England England | 204723380001 | |||||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secretario | Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st Floor East England England | 190361630001 | |||||||
| LAKIN, Helen Mary | Secretario | Gorphwysfa 6 Nant Road Bwlchgwyn LL11 5YN Wrexham Clwyd | British | 41250190001 | ||||||
| LOCKWOOD, Angela | Secretario | Lloyds Banking Group Trinity Road HX1 2RG Halifax C/O Retail Company Secretaries United Kingdom | British | 115797910001 | ||||||
| MAYER, Sally | Secretario | 48 Prospect Street Shibden Heights HX3 6LG Halifax | British | 75435950002 | ||||||
| MOULTON-BRADY, Steven | Secretario | Floor East Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st England England | 183850490001 | |||||||
| NIXON, Raymond | Secretario | Holly House The Steadings Wicker Lane, Guilden Sutton CH3 7EL Chester Cheshire | British | 36433110016 | ||||||
| SOBO, Femi | Secretario | 5 Carr Bridge View Cookridge LS16 7BR Leeds | British | 55778050002 | ||||||
| AITKEN, Stephen | Director | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat United Kingdom | United Kingdom | British,Australian | 188712540001 | |||||
| BAYLEY, Sara Jayne | Director | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | United Kingdom | British | 238307600001 | |||||
| BUCKLEY, Paul | Director | The Orchard Bostock Grange Mews Brick Kiln Lane CW10 9JJ Middlewich | British | 94161290001 | ||||||
| CORFIELD, Elyn Jane | Director | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | United Kingdom | British | 182118580002 | |||||
| CUTBILL, Martin James | Director | 4 Lawnsdale Cuddington CW8 2UT Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 54154380001 | |||||
| DUGGAN, Gary John | Director | 6 Latham Way L63 9NX Spital Wirral | British | 74792420001 | ||||||
| DUGGAN, Gary John | Director | 6 Latham Way L63 9NX Spital Wirral | British | 74792420001 | ||||||
| FACCI, Dominic Jeremy | Director | 1 Cherrywood Crescent B91 3XU Solihull West Midlands | England | British | 110859190001 | |||||
| FOWLER, Louise Helen | Director | 1 Egerton Road Davenport SK3 8SR Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 284520580001 | |||||
| FRANKLIN, Timothy Alan | Director | Wood Lawn Cottage Wood Lane ST14 8JR Uttoxeter Staffordshire | Uttoxeter | British | 82709500001 | |||||
| GALASSI, James Giuliano | Director | Miller Street M60 0AL Manchester Floor 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 192046820001 | |||||
| GARROD, Claire Louise | Director | Bishopsgate EC2M 3YB London 155 United Kingdom | United Kingdom | British | 185920720001 | |||||
| GITTINS, Paul | Director | 5 Hambledon Close Little Sutton L66 4YF South Wirral | British | 45660860002 | ||||||
| GOGOI, Hiral | Director | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | United Kingdom | British | 304121720001 | |||||
| GORDON, Paul Andrew | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 195107520002 | |||||
| GOSLING, Clare Louise | Director | Cis Tower, 18th Floor Miller Street M60 0AL Manchester The Co-Operative Bank England England | United Kingdom | British | 204863170001 | |||||
| GREGORY, Gerald Arthur | Director | Gatepiece House Quarry Bank DE4 3LF Matlock Derbyshire | England | British | 31843730001 | |||||
| GRIFFITHS, Steven Thomas | Director | 1 Deganwy Close CH7 3QB Buckley Flintshire | British | 70889350001 | ||||||
| HAYES, Francis Michael | Director | 42 Eaton Road CW6 0DG Tarporley Cheshire | British | 110859030001 | ||||||
| HILLIARD, Brett Jonathen | Director | Micklegate Mickle Trafford CH2 4TF Chester 2 United Kingdom | England | British | 114396070001 | |||||
| HILLON, James | Director | 2nd Floor Miller Street M60 0AL Manchester Co-Operative Bank United Kingdom | United Kingdom | British | 170882350001 | |||||
| HOSSACK, Ian | Director | 123 Higher Lane WA13 0BU Lymm Cheshire | England | British | 110558740002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BOS PERSONAL LENDING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Co-Operative Bank P.L.C. | 06 abr 2016 | 1 Balloon Street M60 4EP Manchester PO BOX 101 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0