LFI1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLFI1 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03420548
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LFI1 LIMITED?

    • Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LFI1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LFI1 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEATHERHEAD FOOD INTERNATIONAL LIMITED12 ago 200212 ago 2002
    LFRA LIMITED07 dic 199907 dic 1999
    CITEGOOD LIMITED15 ago 199715 ago 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LFI1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LFI1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    23 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 sept 2018

    18 páginasLIQ03

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 07 ene 2017

    2 páginas3.6

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    4 páginasRM02

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    4 páginasRM02

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 sept 2017

    17 páginasLIQ03

    Informe de progreso del administrador hasta 05 sept 2016

    19 páginas2.24B

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 15 mar 2016

    15 páginas2.24B

    Nombramiento de un administrador concursal o gestor

    4 páginasRM01

    Nombramiento de un administrador concursal o gestor

    4 páginasRM01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed leatherhead food international LIMITED\certificate issued on 10/12/15
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 22 oct 2015

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Resultado de la reunión de acreedores

    3 páginas2.23B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    12 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    47 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de Randalls Road Leatherhead Surrey KT22 7RY a Allen House 1 Westmead Road Sutton Surrey SM1 4LA el 29 sept 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 04 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 sept 2015

    Estado de capital el 28 sept 2015

    • Capital: GBP 4,623,776
    SH01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cese del nombramiento de Jonathan Nicholas Gordon-Smith como director el 26 sept 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Nicholas Gordon-Smith como secretario el 26 sept 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr James Ross Hiley como director el 26 sept 2014

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de LFI1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HILEY, James
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Secretario
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    191289160001
    CLARKE, Belinda Rosanna, Dr
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Director
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    United KingdomBritish166159650002
    HILEY, James Ross
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Director
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    EnglandBritish102442450002
    SAMUEL, Michael John, Mr.
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Director
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    EnglandBritish13896090003
    SPRIEGEL, Geoffrey Donald, Dr
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    Director
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    Surrey
    United KingdomBritish28327940001
    CROSER, William James
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    Secretario
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    British58808760002
    GARDNER, Michael
    11 St Leonards Close
    OX9 5PQ Watlington
    Oxfordshire
    Secretario
    11 St Leonards Close
    OX9 5PQ Watlington
    Oxfordshire
    British16045160001
    GORDON-SMITH, Jonathan Nicholas
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Secretario
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    British112761660002
    QUINN, Brian Gerald
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    Secretario
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    British37003910002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BECKETT, Peter Charles
    41 Russell Hill Road
    CR8 2LD Purley
    Surrey
    Director
    41 Russell Hill Road
    CR8 2LD Purley
    Surrey
    United KingdomBritish20786120001
    BERRYMAN, Paul Marcel, Dr
    Pear Tree Cottage
    Cheriton
    SO24 OPW Alresford
    Hampshire
    Director
    Pear Tree Cottage
    Cheriton
    SO24 OPW Alresford
    Hampshire
    Great BritainBritish114447040001
    BEVINGTON, John David
    Bramble Hill
    Heath Way
    KT24 5ET East Horsley
    Surrey
    Director
    Bramble Hill
    Heath Way
    KT24 5ET East Horsley
    Surrey
    British77280360001
    BOOTE, Amanda
    141 High Road
    KT14 7RJ Byfleet
    Surrey
    Director
    141 High Road
    KT14 7RJ Byfleet
    Surrey
    British113674480001
    CROSER, William James
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    Director
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    British58808760002
    FORAGE, Alan James, Dr
    3 Berkley Road
    Knotty Green
    HP9 2AY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    3 Berkley Road
    Knotty Green
    HP9 2AY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British19925910001
    FRY, Ann
    Amethyst House
    Odiham Road
    RG27 8BU Winchfield
    Hampshire
    Director
    Amethyst House
    Odiham Road
    RG27 8BU Winchfield
    Hampshire
    EnglandBritish73546060001
    GORDON SMITH, Jonathan
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Director
    169 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Great BritainBritish112761660001
    GORDON-SMITH, Jonathan Nicholas
    169 Cavendish Meads
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    Director
    169 Cavendish Meads
    SL5 9TG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish112761660002
    HANLEY, Anthony Bryan, Dr
    4 Tudor Walk
    KT22 7HX Leatherhead
    Surrey
    Director
    4 Tudor Walk
    KT22 7HX Leatherhead
    Surrey
    British99475600001
    HARGREAVES, Neil Graham, Dr
    6 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    Director
    6 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish113674240001
    HARRIS, Alan Anthony
    5 Eriswell Crescent
    KT12 5DS Walton On Thames
    Surrey
    Director
    5 Eriswell Crescent
    KT12 5DS Walton On Thames
    Surrey
    British45879630001
    HOWLING, David, Dr
    38 Taunton Road
    M33 5DN Sale
    Cheshire
    Director
    38 Taunton Road
    M33 5DN Sale
    Cheshire
    British7194300001
    JANES, Mark Brough
    Randalls Road
    Leatherhead
    KT22 7RY Surrey
    Director
    Randalls Road
    Leatherhead
    KT22 7RY Surrey
    United KingdomBritish53089340001
    KIERSTAN, Marek Piotr Jacek, Doctor
    149 High Street
    Sawston
    CB2 4HJ Cambridge
    Director
    149 High Street
    Sawston
    CB2 4HJ Cambridge
    British38879800002
    PEACOCK, Brian David
    87 George Lane
    Notton
    WF4 2NQ Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    87 George Lane
    Notton
    WF4 2NQ Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish3314300001
    PENMAN, Alistair, Dr
    Trefenna
    Bubnell Lane
    DE45 1RL Baslow
    Derbyshire
    Director
    Trefenna
    Bubnell Lane
    DE45 1RL Baslow
    Derbyshire
    United KingdomBritish100933740001
    PUGH, Richard Forrest, Doctor
    5 Warren Way
    AL6 0DQ Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    5 Warren Way
    AL6 0DQ Welwyn
    Hertfordshire
    British47763170001
    QUINN, Brian Gerald
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    Director
    10 Rydens Park
    KT12 3DP Walton On Thames
    Surrey
    British37003910002
    REEVES, Anthony Raymond
    2 Willincroft Cottages
    Pinvin
    WR10 2LB Pershore
    Worcestershire
    Director
    2 Willincroft Cottages
    Pinvin
    WR10 2LB Pershore
    Worcestershire
    British67811450001
    ROLFE, Peter
    Greenfields
    Sandy Way, Maybury
    GU2 2BB Woking
    Surrey
    Director
    Greenfields
    Sandy Way, Maybury
    GU2 2BB Woking
    Surrey
    British124178380001
    SHAPLEY, Giles Martin William
    133 Elmbridge Avenue
    Surbiton
    KT5 9HE Surrey
    Director
    133 Elmbridge Avenue
    Surbiton
    KT5 9HE Surrey
    Other95621860001
    YOUNG, John Nigel
    7 The Moorings
    Bookham
    KT23 3QA Leatherhead
    Surrey
    Director
    7 The Moorings
    Bookham
    KT23 3QA Leatherhead
    Surrey
    British70068810001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene LFI1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 21 may 2007
    Entregado el 08 jun 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the trustees of the leatherhead international pension scheme (the scheme) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land and buildings lying on the east side of randalls way leatherhead.
    Personas con derecho
    • Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation PLC in Theircapacity as Trustees of the Leatherhead International Pension Scheme
    Transacciones
    • 08 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 209 feb 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 309 feb 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 209 feb 2018Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
    • 209 feb 2018Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 2
      • Número de expediente 3
    Legal charge
    Creado el 13 feb 2007
    Entregado el 14 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the trustees of the leatherhead international pension scheme under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land and buildings lying on the east side of randalls way, leatherhead. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Geoffrey Ford, Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation Plcas Trustees of the Scheme (The Trustees)
    Transacciones
    • 14 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 sept 2006
    Entregado el 09 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land and buildings lying on the east side of randalls way, leatherhead.
    Personas con derecho
    • Geoffrey Ford, Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation PLC International Pension Scheme
    • Geoffrey Ford, Brian Gandy and Mike Marrs and the Law Debenture Pension Trust Corporation Plcin Their Capacity as Trustees of the Leatherhead
    Transacciones
    • 09 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 10 nov 2005
    Entregado el 11 nov 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a leatherhead foods international limited randalls road leatherhead.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 nov 2005Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene LFI1 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    16 sept 2015Inicio de la administración
    05 sept 2016Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Profesional
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Profesional
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    2Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter John Cambray Loveday
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Administrador judicial/gestor
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Administrador judicial/gestor
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    3Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter John Cambray Loveday
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Administrador judicial/gestor
    2 Southwark Street
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Administrador judicial/gestor
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    4
    FechaTipo
    05 sept 2016Inicio de la liquidación
    30 dic 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Liquidador propuesto
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Liquidador propuesto
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Profesional
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Profesional
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0