CIVICEASY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CIVICEASY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03422540 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CIVICEASY LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CIVICEASY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CIVICEASY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CIVICEASY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Wendy Margaret Hall como director el 01 ene 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Shepherd como director el 31 dic 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Thorsten Beer como director el 03 sept 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Willetts como director el 03 sept 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Nichola Louise Legg como secretario el 25 jul 2012 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Anne Brierley como secretario el 25 jul 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr William Shepherd como director el 01 ago 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Smerdon como director el 01 ago 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 ago 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Jennifer Anne Brierley el 01 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 ago 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CIVICEASY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGG, Nichola Louise | Secretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
| BEER, Thorsten | Director | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| HALL, Wendy Margaret | Director | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | 172979860001 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Secretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Secretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| MEHDI, Mohammed | Secretario | 13 Drove Road Throckley NE15 9DS Newcastle Upon Tyne | British | 56130280001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| HOOD, John | Director | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| MAK, Yat Keung | Director | 4 Careen Crescent Middle Herrington SR3 3TF Sunderland Tyne & Wear | British | 23718690001 | ||||||
| MEHDI, Mohammed | Director | 13 Drove Road Throckley NE15 9DS Newcastle Upon Tyne | British | 56130280001 | ||||||
| SHEPHERD, William | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| WILLETTS, Andrew John | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene CIVICEASY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 29 abr 2003 Entregado el 13 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 43/45 frederick street and 49 walpole street south shields tyne & wear (TY174479. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 dic 1998 Entregado el 15 dic 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage the medical centre new george street south shields..8 Sea road fulwell sunderland..191 Laygate south shields. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 08 dic 1997 Entregado el 18 dic 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0