GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03428547 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| WIMPEY HOMES EAST MIDLANDS LIMITED | 02 abr 2001 | 02 abr 2001 |
| MCLEAN HOMES EAST MIDLANDS LIMITED | 03 sept 1997 | 03 sept 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 22 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como director el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como secretario el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como director el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 21 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 21 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 05 jul 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como secretario el 05 jul 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 páginas | AD03 | ||
¿Quiénes son los directivos de GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 340891210001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secretario | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 310957230001 | |||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 147318690001 | |||||||
| BORT, Stefan Edward | Secretario | 126 Grove Park SE5 8LD London | British | 32824200005 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 322296310001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Secretario | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219913070001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 166109700001 | |||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secretario | 78 Long Drive HA4 0HP South Ruislip Middlesex | British | 34521340004 | ||||||
| PHILLIPS, James | Secretario | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Director | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | 193735640001 | |||||
| ANDREW, Peter Robert | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| BEESTON, David James | Director | Chesnut Cottage 1 Middle Lane, LE14 3HD Nether Broughton Leicestershire | British | 75749340001 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Director | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | England | British | 130306120001 | |||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| CUSHEN, Keith Morgan | Director | Buddleia Cottage High Street TW12 2SX Hampton Middlesex | British | 37763770002 | ||||||
| CZERNIUK, Martin Colin | Director | 19 Rookery Lane Stoke Bruerne NN12 7SJ Towcester Northamptonshire | England | British | 80767900002 | |||||
| DIFFIN, Michael | Director | 10 Hillside Drive NG25 0JZ Southwell Nottinghamshire | England | British | 120145510001 | |||||
| DYKE, Ian David | Director | 41 Elm Tree Avenue Glenfield LE3 8QA Leicester Leicestershire | British | 54646680003 | ||||||
| FARMER, Stephen William | Director | 24 Cheriton Drive DE7 9HP Ilkeston Derby Derbyshire | British | 75749400001 | ||||||
| GILBERT, Robert Charles | Director | 24 Gloucester Close St Nicholas Park CV11 6FU Nuneaton Warwickshire | United Kingdom | British | 75749240001 | |||||
| HARTSHORN, Lynne | Director | Woods Meadow Elvaston DE72 3UX Derby 1 Derbyshire | British | 136640360001 | ||||||
| HIBBERT, Basil John | Director | 31 Lawn Close DE75 7TR Heanor Derby Derbyshire | British | 75749210001 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| JENKINS, Stephen Adrian | Director | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 49738660003 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Director | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Director | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 | |||||
| REDFERN, Peter Timothy | Director | 5 Broadfield Road OX5 1UL Yarnton Oxfordshire | British | 74208670003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GEORGE WIMPEY EAST MIDLANDS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Wimpey Uk Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0