LLNH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLLNH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03429499
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LLNH LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra LLNH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Southgate House
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LLNH LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEND LEASE NH LIMITED07 ene 199807 ene 1998
    LEND LEASE HOMES LIMITED11 sept 199711 sept 1997
    HACKREMCO (NO.1266) LIMITED04 sept 199704 sept 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LLNH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LLNH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Situations in which directors have or can have a direct or indirect interest that conflicts with interest of the company authorised, notwithstanding that any such conflict may breach director's duty under S175 of CA2006. 25/08/2021
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2020

    9 páginasAA

    Cancelación total de la carga 034294990011

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 034294990013

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 034294990012

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 034294990014, creada el 27 abr 2021

    57 páginasMR01

    Registro de la carga 034294990016, creada el 27 abr 2021

    90 páginasMR01

    Registro de la carga 034294990015, creada el 27 abr 2021

    216 páginasMR01

    Nombramiento de Mr James Walter Tugendhat como director el 14 sept 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2019

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de James Justin Hutchens como director el 05 feb 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr James Justin Hutchens el 08 ene 2018

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Chaitanya Bhupendra Patel como director el 22 sept 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr James Justin Hutchens como director el 21 sept 2017

    2 páginasAP01

    Cancelación total de la carga 034294990010

    4 páginasMR04

    Registro de la carga 034294990013, creada el 30 jun 2017

    47 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de LLNH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    Director
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    England
    United KingdomBritish147997950001
    TUGENDHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Director
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomBritish218306870001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    Secretario
    Flat 1 Basement
    269 Magdalen Road Earlsfield
    SW18 3NZ London
    British106745220001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Secretario
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Secretario
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    KILMARTIN, Adrian Robert
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    Secretario
    Church Farm
    Acton Turville
    GL9 1HD Badminton
    South Gloucestershire
    British11660010001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Secretario
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Secretario
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    British110640170001
    MORTIMER, Rachel
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    Secretario
    14 Huron Road
    SW17 8RB London
    British102674500002
    PANG, Lily
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Secretario
    Calbourne Road
    SW12 8LW London
    9
    United Kingdom
    Malaysian140239060001
    SUTTON, Penelope Ruth
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    Secretario
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    British38586070002
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secretario designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ARTHUR, Derryn Sue
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    Director
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    New Zealander57726590002
    AUBERY, Paul Richard
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    Director
    1 Malthouse Drive Regency Quay
    Chiswick
    W4 2NR London
    British78253140001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Director
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BLITZER, David Scott
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Director
    5 Priory Walk
    SW10 9SP London
    EnglandAmerican82685720001
    BURROWS, Roger Leonard
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Director
    51 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3BH Richmond
    Surrey
    Australian47271870002
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Director
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Director
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Director
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Director
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    DAVIES, William Jeremy
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    Director
    The Manor House
    Great Somerford
    SN15 5EH Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish21505070001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Director
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    ELLERT, Richard John
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    Director
    Cami Del Padro 10
    Sant Vicenc De Montalt
    Barcelona
    Catalonia 08394
    Spain
    British95944260001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FRANCIS, Daniel Fernley
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    Director
    Bartley Lodge 11 Marlborough Road
    Chandlers Ford
    SO53 5DJ Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish44830480001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Director
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Director
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Director
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomAmerican238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Director
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    MARSHALL, Ian
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    Director
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    British81232950001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Director
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Director
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Director
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LLNH LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Nhp Limited
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    01 may 2017
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    Durham
    England
    No
    Forma jurídicaLimited
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro02798607
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene LLNH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 27 abr 2021
    Entregado el 29 abr 2021
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 29 abr 2021Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 abr 2021
    Entregado el 29 abr 2021
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 29 abr 2021Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 abr 2021
    Entregado el 29 abr 2021
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 29 abr 2021Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 30 jun 2017
    Entregado el 10 jul 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 10 jul 2017Registro de una carga (MR01)
    • 30 abr 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 jun 2017
    Entregado el 07 jul 2017
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 07 jul 2017Registro de una carga (MR01)
    • 30 abr 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 jun 2017
    Entregado el 06 jul 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Trustee
    Transacciones
    • 06 jul 2017Registro de una carga (MR01)
    • 30 abr 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 12 nov 2014
    Entregado el 21 nov 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hcp, Inc. (As Security Agent)
    Transacciones
    • 21 nov 2014Registro de una carga (MR01)
    • 14 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A security deed
    Creado el 15 ene 2007
    Entregado el 30 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse, London Branch
    Transacciones
    • 30 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite debenture
    Creado el 12 dic 2006
    Entregado el 21 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 oct 2005
    Entregado el 20 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 20 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 18 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 abr 2005
    Entregado el 15 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Insurance policies, hedging documents, accounts, occupational leases, all land and proceeds of sale, plant and machinery, rents, specified investments, derivative rights, goodwill & uncalled capital, all receivables, intercompany debt, each account floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 15 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 11 jun 1998
    Entregado el 18 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage f/h interest in aberford hall nursing home oakwood green roundhay leeds LS8 2QU t/n-WYK510482, ascot lodge nursing home 48A newlands road intake sheffield S12 2FZ t/n-SYK354711, aston house nursing home 26 angel lane hayes middlesex UB3 2QX t/n-NGL47781 (see 395 for other properties charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transacciones
    • 18 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 03 jun 1998
    Entregado el 08 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Each and every liability that the obligors (as therein defined) may have to the chargee under or pursuant to the facility documents (as defined in the facility agreement dated 28 january 1998) (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998)
    Breve descripción
    The f/h interest in the property k/a ashton grange residential home st lukes road pallion sunderland t/n TY304629, windsor court bartholomew avenue goole east riding of yorkshire t/n HS170159, ashbourne lodge nursing home ryhope road grangetown sunderland t/n TY310171 and victoria house residential home bath lane stockton on tees t/n CE136807 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 08 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture made between (1) llnhp partnership acting through its partners (2) nhp securities no.4 Limited and (3) lend lease nh limited in favour of the governor and company of the bank of scotland as security trustee
    Creado el 06 may 1998
    Entregado el 11 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture)
    Breve descripción
    All rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property k/a the beeches nursing home 55 furlong road arnold nottingham. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creado el 10 feb 1998
    Entregado el 24 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Each and every liability which the obligors (as therein defined) have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents as defined in the facility agreement (including the facility agreement and the debenture dated 28 january 1998) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum now or hereafter owing due or incurred by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Breve descripción
    All rights and claims in relation to the real property being - the f/h ladymead nursing home canal way devizes wiltshire t/n WT133199 avonmead nursing home canal way devises wiltshire t/n's WT132231, WT142939 and WT154929 and kingsmead nursing home prospect place old town swindon wiltshire t/n's WT16064, WT139496 and WT137926. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandthe "Security Trustee"
    Transacciones
    • 24 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 30 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 ene 1998
    Entregado el 03 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Each and every liability which the obligors (as defined) have to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and every sum at the date of the debenture or thereafter owing by the obligors to the security trustee or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    Breve descripción
    A.the real property other than scottish real property and the northern irish real property;B.all rights and claims to which llnhp and each partner is at the date of the debenture or may thereafter become entitled in relation to all monies at the date of the debenture or at any time standing to the credit of any bank accounts.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 25 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0