CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED

CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCELINE GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03430071
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Second Floor
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DEBENHAMS GROUP HOLDINGS LIMITED18 abr 200618 abr 2006
    DEBENHAMS LIMITED02 mar 200402 mar 2004
    DEBENHAMS PLC04 dic 199704 dic 1997
    ROBERTSCO PLC01 sept 199701 sept 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 ago 2019
    Próximas cuentas vencen el31 ago 2020
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 sept 2018

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta22 jul 2020
    Próxima declaración de confirmación vence02 sept 2020
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta22 jul 2019
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Informe de progreso en una liquidación por el tribunal

    16 páginasWU07

    Informe de progreso en una liquidación por el tribunal

    16 páginasWU07

    Nombramiento de un liquidador

    3 páginasWU04

    Orden del tribunal para liquidar

    3 páginasCOCOMP

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Informe de progreso del administrador

    21 páginasAM10

    Aviso de orden judicial para finalizar la administración

    24 páginasAM25

    Informe de progreso del administrador

    18 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    22 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    24 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA

    11 páginasAM02

    Informe de progreso del administrador

    23 páginasAM10

    Declaración de la propuesta del administrador

    26 páginasAM03

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Declaración de la propuesta del administrador

    26 páginasAM03

    Domicilio social registrado cambiado de 334 - 348 Oxford Street London W1C 1JG England a Second Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU el 19 sept 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Cese del nombramiento de Sally Hopwood como secretario el 24 jun 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Jeffrey James Holder como director el 22 may 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mike Hazell como director el 22 may 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stefaan Vansteenkiste como director el 22 may 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicola Kinnaird como director el 08 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Adams como director el 08 abr 2020

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOLDER, Jeffrey James
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Second Floor
    Director
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Second Floor
    EnglandBritishDirector231110670001
    DARWALL, Alice Ann
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Secretario
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    257967160001
    EARDLEY, Paul Rex
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Secretario
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    BritishSolicitor74477320006
    HARRISON, Rosalynde
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    Secretario
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    251965770001
    HOPWOOD, Sally
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Secretario
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    265358750001
    JOHNSON, Guy Antony
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Secretario
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    BritishSolicitor29729020004
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Upper Walland Farm
    TN5 6NE Wadhurst
    Sussex
    Secretario
    Upper Walland Farm
    TN5 6NE Wadhurst
    Sussex
    BritishFinance Director152077790001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Upper Walland Farm
    TN5 6NE Wadhurst
    Sussex
    Secretario
    Upper Walland Farm
    TN5 6NE Wadhurst
    Sussex
    BritishFinance Dir152077790001
    ROBERTS, Julie Amanda
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    Secretario
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    British57062440002
    WILSON, David, Dr
    7 Cleaver Square
    Kennington
    SE11 4DW London
    Secretario
    7 Cleaver Square
    Kennington
    SE11 4DW London
    British147719290001
    ADAMS, David
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Director
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    EnglandBritishCompany Director239339020001
    BAULK, Michael Robert Gordon
    Cawsand Place
    West Drive Wentworth
    GU25 4NE Virginia Water
    Surrey
    Director
    Cawsand Place
    West Drive Wentworth
    GU25 4NE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishNon-Executive Director13148210001
    BUCHER, Sergio Rodriguez
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomSpanishCompany Director216512370001
    CLARKE, Timothy
    63 Wellington Road
    B15 2ET Edgbaston
    Birmingham
    Director
    63 Wellington Road
    B15 2ET Edgbaston
    Birmingham
    EnglandBritishNon-Executive Director149229730001
    COSTELETOS, Phillipe Marinos
    52 Kensington Place
    W8 7PR London
    Director
    52 Kensington Place
    W8 7PR London
    GreekPrivate Equity Investor74664800001
    COSTELETOS, Phillipe Marinos
    52 Kensington Place
    W8 7PR London
    Director
    52 Kensington Place
    W8 7PR London
    GreekPrivate Equity Inv74664800001
    DUDDY, Terence
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Director
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    EnglandBritishCompany Director256736950001
    EARL, Belinda Jane
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Director
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    BritishChief Executive83465380001
    FEUER, Jonathan Philip
    Maytrees
    Granville Road
    KT13 0QG Weybridge
    Surrey
    Director
    Maytrees
    Granville Road
    KT13 0QG Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director Cvc Capital142718980001
    FEUER, Jonathan Philip
    Maytrees
    Granville Road
    KT13 0QG Weybridge
    Surrey
    Director
    Maytrees
    Granville Road
    KT13 0QG Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director Cvc142718980001
    GEDEON, Ramzi
    50 St Mary Abbot's Court
    Warwick Gardens
    W14 8RB London
    Director
    50 St Mary Abbot's Court
    Warwick Gardens
    W14 8RB London
    United KingdomBritishPrivate Equity Investor100678460001
    GREEN, Terence Anthony
    Silverlands
    Boars Head
    TN6 3HE Crowborough
    East Sussex
    Director
    Silverlands
    Boars Head
    TN6 3HE Crowborough
    East Sussex
    BritishChief Executive24298390003
    GUILLAUME, Jane Heather Ruth
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Director
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    BritishPersonnel Director54957590004
    HARLOW, Suzanne
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director183585370001
    HAZELL, Mike
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Director
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    EnglandBritishCompany Director263031350002
    HERRICK, Simon Edward
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Director
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director70414940003
    HILL, Robert David
    23 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    23 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishVenture Capital97917690001
    HOSKYNS, John Austin Hungerford Leigh, Sir
    Windrush
    Great Waldingfield
    CR10 0RZ Sudbury
    Suffolk
    Director
    Windrush
    Great Waldingfield
    CR10 0RZ Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector37474760001
    JARVIS, Peter Jack
    Badgers Raughmere Court
    Raughmere Drive Lavant
    PO18 0DT Chichester
    West Sussex
    Director
    Badgers Raughmere Court
    Raughmere Drive Lavant
    PO18 0DT Chichester
    West Sussex
    BritishNon-Executive Chairman5267700002
    KAURSLAND, Peter Thomas
    The Springs Howe Road
    OX9 5EL Watlington
    Oxfordshire
    Director
    The Springs Howe Road
    OX9 5EL Watlington
    Oxfordshire
    BritishManaging Director28697660001
    KINNAIRD, Nicola
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Director
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    EnglandBritishCompany Director32458300001
    LOVERING, John David
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    Director
    91 Wimpole Street
    W1G 0EF London
    United KingdomBritishDirector73573160004
    OSBORNE, Rachel Claire Elizabeth
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    Director
    W1C 1JG London
    334 - 348 Oxford Street
    England
    United KingdomBritishChief Financial Officer250468300001
    PADOVANO, Guido
    Rua Franca 83
    Sao Paulo
    Sp 01446 010
    Brazil
    Director
    Rua Franca 83
    Sao Paulo
    Sp 01446 010
    Brazil
    ItalianCorporate Executive92441240001
    PADOVANO, Guido
    Rua Franca 83
    Sao Paulo
    Sp 01446 010
    Brazil
    Director
    Rua Franca 83
    Sao Paulo
    Sp 01446 010
    Brazil
    ItalianCorporate Executive92441240001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Celine Uk Newco 1 Limited
    Oxford Street
    W1C 1JG London
    334-348
    England
    09 abr 2019
    Oxford Street
    W1C 1JG London
    334-348
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro11899940
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Brock Street
    Regent's Place
    NW1 3FG London
    10
    United Kingdom
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro5448421
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 ene 2020
    Entregado el 28 ene 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    Argentine trade mark registration number 2421249 and the additional ip listed in part 6 intellectual property rights) of schedule 2 of the attached charging document.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 28 ene 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2019
    Entregado el 21 oct 2019
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 21 oct 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 09 abr 2019
    Entregado el 11 abr 2019
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 11 abr 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 29 mar 2019
    Entregado el 01 abr 2019
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 01 abr 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 11 feb 2019
    Entregado el 19 feb 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    N/A.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transacciones
    • 19 feb 2019Registro de una carga (MR01)
    • 04 abr 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creado el 27 jun 2005
    Entregado el 06 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee, as owed or incurred by each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse,London Branch
    Transacciones
    • 06 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession and charge
    Creado el 12 dic 2003
    Entregado el 18 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse First Boston
    Transacciones
    • 18 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CELINE GROUP HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 ago 2020Inicio de la administración
    18 ago 2022Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profesional
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip James Watkins
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profesional
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2
    FechaTipo
    05 jul 2022Fecha de la petición
    14 jul 2022Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Philip James Watkins
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profesional
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Profesional
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    The Official Receiver Or London
    16th Floor 1 Westfield Avenue
    Stratford
    E20 1HZ London
    Profesional
    16th Floor 1 Westfield Avenue
    Stratford
    E20 1HZ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0