RELAND (WEEDON) LIMITED

RELAND (WEEDON) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRELAND (WEEDON) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03435816
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RELAND (WEEDON) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CAVALRY CENTRE LIMITED20 nov 199720 nov 1997
    HUNTERMILE LIMITED18 sept 199718 sept 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Jonathan Ross Brodie como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Jonathan Ross Brodie el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 sept 2015

    Estado de capital el 07 sept 2015

    • Capital: GBP 32
    SH01

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 sept 2014

    Estado de capital el 08 sept 2014

    • Capital: GBP 32
    SH01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de RELAND (WEEDON) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147811200001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Secretario
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    British35117250001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secretario designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Secretario
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Director
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Director
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    Director
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish110978610002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Director
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Director
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Director designado
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Director designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MILLIGAN, Michael
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    Director
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish153845120001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    ¿Tiene RELAND (WEEDON) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A bond and floating charge
    Creado el 01 sept 2009
    Entregado el 14 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The charged assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 14 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 01 sept 2009
    Entregado el 14 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the each obligor and each residential obligor to any commercial secured party and any residential secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 14 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2009
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 09 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 jul 2000
    Entregado el 27 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 21 nov 1997
    Entregado el 03 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 nov 1997
    Entregado el 03 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0