T (PARTNERSHIP) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | T (PARTNERSHIP) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03436754 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de T (PARTNERSHIP) LIMITED?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra T (PARTNERSHIP) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Level 19, The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de T (PARTNERSHIP) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TESCO (PARTNERSHIP) LIMITED | 19 feb 1998 | 19 feb 1998 |
| TGP (PARTNERSHIP) LIMITED | 19 nov 1997 | 19 nov 1997 |
| TESCO (GENERAL PARTNER) LIMITED | 19 sept 1997 | 19 sept 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de T (PARTNERSHIP) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para T (PARTNERSHIP) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 03 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para T (PARTNERSHIP) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Sgh Company Secretaries Limited como secretario el 15 oct 2025 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Hafren Advisory Limited como secretario el 15 oct 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor 10 Bishops Square London E1 6EG England a Level 19, the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG el 15 oct 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Mr Michael Graham Perkins el 06 ago 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Martin Austen como director el 13 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Robert Henry Abraham como director el 13 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Graham Perkins como director el 13 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Atrato Partners Limited como secretario el 29 may 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Hafren Advisory Limited como secretario el 29 may 2025 | 2 páginas | AP04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 19 páginas | AA | ||
Modification des détails de Supermarket Income Investments Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 feb 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Atrato Partners Limited como secretario el 17 feb 2025 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Hanway Advisory Limited como secretario el 16 feb 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Scalpel 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF United Kingdom a 3rd Floor 10 Bishops Square London E1 6EG el 18 feb 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del secretario Hanway Advisory Limited el 03 oct 2024 | 1 páginas | CH04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Supermarket Income Investments Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1 King William Street London EC4N 7AF United Kingdom a The Scalpel 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF el 08 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Registro de la carga 034367540005, creada el 22 abr 2024 | 62 páginas | MR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 034367540004, creada el 14 sept 2023 | 63 páginas | MR01 | ||
Cese del nombramiento de Jtc (Uk) Limited como secretario el 05 may 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Hanway Advisory Limited como secretario el 05 may 2023 | 2 páginas | AP04 | ||
¿Quiénes son los directivos de T (PARTNERSHIP) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGH COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 32 London Bridge Street SE1 9SG London C/O Ampa Holdings Llp, Level 19, The Shard United Kingdom |
| 153537380001 | ||||||||||
| ABRAHAM, Robert Henry | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 19, The Shard United Kingdom | United Kingdom | British | 329197580001 | |||||||||
| PERKINS, Michael Graham | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 19, The Shard United Kingdom | United Kingdom | British | 286926380002 | |||||||||
| BAILEY, John Anthony | Secretario | Games Road EN4 9HX Barnet Ludgrove Hall 61-65 Hertfordshire | British | 134568600001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretario | Seymour Street W1H 7LX London York House 45 | 202711580001 | |||||||||||
| FIELD, Martin John | Secretario | 1 Hole Farm Cottages Albury Hall Park Albury SG11 2JE Ware Hertfordshire | British | 71986450002 | ||||||||||
| O'KEEFE, Helen Jane | Secretario | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 96031250001 | ||||||||||
| SANKAR, Nadine Amanda | Secretario | 90 Ebury Road WD17 2SB Watford | British | 72917320001 | ||||||||||
| ATRATO PARTNERS LIMITED | Secretario corporativo | c/o Hillier Hopkins First Floor 51 Clarendon Road WD17 1HP Watford Radius House England |
| 332502890001 | ||||||||||
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| HAFREN ADVISORY LIMITED | Secretario corporativo | 10 Bishops Square E1 6EG London 3rd Floor England |
| 336447720001 | ||||||||||
| HANWAY ADVISORY LIMITED | Secretario corporativo | 18th Floor 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel United Kingdom |
| 251377070001 | ||||||||||
| JTC (UK) LIMITED | Secretario corporativo | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel, 18th Floor England |
| 83237780001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| TESCO SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt New Tesco House Herts United Kingdom |
| 182118090001 | ||||||||||
| AGER, Rowley Stuart | Director | Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 72555850002 | |||||||||
| AUSTEN, Jonathan Martin | Director | 18th Floor 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | United Kingdom | British | 51921200001 | |||||||||
| BAILEY, John Anthony | Director | Games Road EN4 9HX Barnet Ludgrove Hall 61-65 Hertfordshire | England | British | 134568600001 | |||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | Seymour Street W1H 7LX London York House 45 | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| FIELD, Martin John | Director | 42 Lygean Avenue SG12 7AR Ware Hertfordshire | British | 71986450003 | ||||||||||
| GIBNEY, John | Director | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 194216530001 | |||||||||
| HAYMAN, Josephine | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 266797860001 | |||||||||
| HOWELL, Robert | Director | 30 Beech Drive N2 9NY London | British | 67469070001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Director | Seymour Street W1H 7LX London York House 45 | England | British | 58257940003 | |||||||||
| LLOYD, Jonathan Mark | Director | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 160028560001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MERCER, Paul Vincent | Director | Clearwater Chapel Road Rowledge GU10 4AN Farnham Surrey | British | 50858220001 | ||||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Director | Seymour Street W1H 7LX London York House 45 | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Director | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 194306140001 | |||||||||
| NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms. | Director | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | United Kingdom | British | 148079740001 | |||||||||
| ROBSON, Tom | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 266793650001 | |||||||||
| TAUNT, Nicholas Henry | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 275050860001 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Director corporativo | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom |
| 175259630001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de T (PARTNERSHIP) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermarket Income Investments Uk Limited | 13 nov 2020 | 10 Bishops Square E1 6EG London 3rd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| British Land (Joint Ventures) Limited | 19 sept 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0