ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED

ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASQUITH DAY NURSERIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03437108
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ASQUITH COURT NURSERIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED15 mar 200415 mar 2004
    GATEHOUSE NURSERY SERVICES (SURREY) LIMITED16 jul 199816 jul 1998
    SPEED 6555 LIMITED19 sept 199719 sept 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Andrew Terry Morris como director el 01 dic 2016

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours raccourci du 28 feb 2017 au 31 dic 2016

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2016

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Stephen Dreier como director el 10 nov 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Dave Lissy como director el 10 nov 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Elizabeth Boland como director el 10 nov 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Stephen Kramer como secretario el 10 nov 2016

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr James Walter Tugendhat como director el 10 nov 2016

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Buckinghamshire HP5 1LH a 2 Crown Way Rushden NN10 6BS el 15 nov 2016

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Adam David Sage como secretario el 10 nov 2016

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2015

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 sept 2015

    Estado de capital el 18 sept 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 sept 2014

    Estado de capital el 05 sept 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 sept 2013

    Estado de capital el 03 sept 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Bucks HP5 1SJ England* el 18 sept 2012

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KRAMER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Secretario
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    218602340001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United StatesAmerican211308080001
    LISSY, Dave
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United StatesAmerican218331690001
    TUGENDHAT, James Walter
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    Director
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    United KingdomBritish218306870001
    AUGHTERSON, Peter William
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    Secretario
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    British Australian37698830004
    BUXTON-SMITH, Maria Rita
    1 Whitsun Pasture
    Willen Park
    MK15 9DQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    1 Whitsun Pasture
    Willen Park
    MK15 9DQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British39442340001
    HENDRIE, Neal Malcolm
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    Secretario
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    British40848270002
    RING, Ronald Arthur
    7 Georgian Close
    Abbeydale
    GL4 5DG Gloucester
    Gloucestershire
    Secretario
    7 Georgian Close
    Abbeydale
    GL4 5DG Gloucester
    Gloucestershire
    British52543770001
    SAGE, Adam David
    c/o Company Secretary
    34 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Asquith House
    Buckinghamshire
    England
    Secretario
    c/o Company Secretary
    34 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Asquith House
    Buckinghamshire
    England
    154051170001
    YARROW, Nicholas John
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    Secretario
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    British127478700001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    AUGHTERSON, Peter William
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    Director
    Farley Hill House Church Lane
    RG7 1UP Farley Hill
    Berkshire
    British Australian37698830004
    FAIRHURST, Russell William
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    Director
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    EnglandBritish44556020003
    FORD, Russell Mark
    Elm Field House
    Moreton
    OX9 2HS Thame
    South Oxfordshire
    Director
    Elm Field House
    Moreton
    OX9 2HS Thame
    South Oxfordshire
    United KingdomBritish108597900005
    HENDRIE, Neal Malcolm
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    Director
    74 The Drive
    UB10 8AQ Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritish40848270002
    MORRIS, Andrew Terry
    The Kiln Malthouse Close
    Ashbury
    SN6 8LN Swindon
    Wiltshire
    Director
    The Kiln Malthouse Close
    Ashbury
    SN6 8LN Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish123609540001
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Director
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    PHILPOTT, Stephen John Randall
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    Director
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    United KingdomBritish45243130001
    RHODES, Phillip Baverstock
    12 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    Director
    12 Peterborough Villas
    SW6 2AT London
    United KingdomBritish103078920001
    RING, Ronald Arthur
    7 Georgian Close
    Abbeydale
    GL4 5DG Gloucester
    Gloucestershire
    Director
    7 Georgian Close
    Abbeydale
    GL4 5DG Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish52543770001
    SAGE, Adam David
    Orbital House
    Park View Road
    HP4 3EY Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    Orbital House
    Park View Road
    HP4 3EY Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish216961780001
    YARROW, Nicholas John
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    Director
    Chiltern View, 27
    Cobbetts Ride
    HP23 4BZ Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish127478700001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Asquith Nurseries Limited
    34 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Asquith House
    England
    06 abr 2016
    34 Germain Street
    HP5 1LH Chesham
    Asquith House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro05133988
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ASQUITH DAY NURSERIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 11 jun 2002
    Entregado el 21 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 21 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    By a security accession deed between the company, chestnutbay limited (the "parent") and dresdner bank ag, london branch (the "security agent") the company acceded to a debenture dated 10 may 2001, between inter alia, the parent and the security agent
    Creado el 10 may 2001
    Entregado el 23 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies or liabilities due, owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future, including all liabilities in connection with any notes, bills or other instruments accepted by any secured party for or at the request of an obligor and all losses incurred by any secured party in connection therewith (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag
    Transacciones
    • 23 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 20 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 jun 1999
    Entregado el 10 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 29 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0