THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED

THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03437534
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MYLOHILL LIMITED22 sept 199722 sept 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2016
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2017
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 034375340017

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 034375340016

    4 páginasMR04

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2016 au 30 sept 2016

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ene 2016

    Estado de capital el 19 ene 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nombramiento de Wfw Legal Services Limited como secretario el 17 jun 2015

    2 páginasAP04

    Domicilio social registrado cambiado de One Fleet Place London EC4M 7WS a 15 Appold Street London EC2A 2HB el 22 jun 2015

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 034375340015

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Gary Reginald Davis como director el 17 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 dic 2014

    Estado de capital el 23 dic 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado One Fleet Place London EC4M 7WS

    1 páginasAD04

    Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 034375340017

    5 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 034375340016

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 034375340015

    5 páginasMR05

    Registro de la carga 034375340017

    18 páginasMR01

    Registro de la carga 034375340016

    18 páginasMR01

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 034375340015

    93 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WFW LEGAL SERVICES LIMITED
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    Secretario corporativo
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1648390
    18093320001
    ROBERTS, Paul
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    Director
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    United KingdomBritishFinance Director168184220001
    ADAMS, Denise
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Secretario
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    British54657810001
    BONELLA, Richard John Murray
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    Secretario
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    British33446940002
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Secretario
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    TUTTY, Roy James
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    The Granary
    Highway Drayton Parslow
    MK17 0JW Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British61146650001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secretario corporativo
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Director
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritishCompany Director34251500001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Director
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritishCompany Director34251500001
    BATE, Simon Donald
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    Director
    27 Southdowns Road
    WA14 3NP Bowden
    Altrincham
    BritishManagement Consultant75874130002
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director9320160002
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor9320160002
    BLACK, Robin Kennedy
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    Director
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant37965380001
    BLUM, Edward Jesse
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    Director
    63 Denton Road
    TW1 2TN Twickenham
    Middlesex
    AmericanEvp-Finance65674420001
    BLURTON, Andrew Francis
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    Director
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director53724380001
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritishCompany Director53724380001
    BOHLMANN, John
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    Director
    4015 Kirkmeadow Lane
    75287 Dallas
    Texas
    Usa
    AmericanCorporate Counsel65674380001
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    Director
    42 Magdalen Road
    SW18 3NP London
    BritishCompany Director38255700004
    CANNON, Phyliss
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Director
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    BritishCo Services Manager55712040001
    CARREKER, James Don
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    Director
    6801 Baltimore
    Dallas 75205
    FOREIGN Texas
    Usa
    AmericanDirector & Company Officer66262660001
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Director
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector102741680001
    COOK, Robert Barclay
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    Director
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    United KingdomBritishChief Executive Officer136758210001
    DAVIS, Gary Reginald
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    Director
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    EnglandBritishCeo167510270002
    DODD, Andrew Gerard
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    Director
    96 Park Road
    WA15 9LF Hale
    Cheshire
    EnglandBritishBusiness Manager74768570001
    ELLIOT, Colin David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritishFinance Director154267590001
    HAINING, Andrew
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    Director
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    BritishInvestment Banker42196640008
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Director
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritishCompany Director69263980002
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Director
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritishDirector69263980002
    MCCULLOCH, Kenneth Wilfred
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    Director
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    ScotlandBritishHotelier37947170001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Director
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector132613500001
    RAYMOND, Anne
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    Director
    9324 Waternew
    Dallas 75218
    FOREIGN Texas
    Usa
    AmericanDirector66261390001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Director
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilianCompany Director51723030002
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Director
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilianCompany Director51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    Director
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritishCompany Director121710890001

    ¿Tiene THE MALMAISON COMPANY (EDINBURGH) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 10 abr 2014
    Entregado el 17 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Malmaison (edinburgh) 1 tower place edinburgh t/no.MID102835.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 nov 2014Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 30 ago 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 abr 2014
    Entregado el 17 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Malmaison (edinburgh) (one) 1 tower place edinburgh t/no.MID113519. (Two) 1-4 tower place t/no.MID91315 and (three) northeast side of tower street edinburgh t/no.MID12575.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 nov 2014Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 30 ago 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 abr 2014
    Entregado el 11 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 11 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 nov 2014Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 22 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 29 feb 2008
    Entregado el 14 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Original Lenders and the Agent) (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 14 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 28TH june 2006 and
    Creado el 22 jun 2006
    Entregado el 12 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All and whole the companys interest in a lease of the land with buildings erected thereon known as malmaison edinburgh 1 tower place leith edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transacciones
    • 12 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 03 jun 2003
    Entregado el 16 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Malmaison hotel 1 tower place leith edinburgh EH6 7DB. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 16 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 9TH june 2003 and
    Creado el 29 may 2003
    Entregado el 25 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All and whole (in the first place) the subjects at tower place/tower street leith lying for the purposes of registration of writs in the county of midlothian shown outlined red on the plan annexed and executed as relative to the disposition by (firstly) international transport limited and (secondly) forth ports PLC in favour of the malmaison company (edinburgh) limited dated 18 and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the count of midlothian on 26 both days of march 1998. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC
    Transacciones
    • 25 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 july 2002 and
    Creado el 26 jun 2002
    Entregado el 17 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due from mwb malmaison holdings limited (the "borrower") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The malmaison hotel,tower place/tower street,leith,edinburgh in the county of midlothian.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 july 2002 and
    Creado el 26 jun 2002
    Entregado el 17 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The malmaison hotel,tower place/tower street,leith,edinburgh in the county of midlothian.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 26 jun 2002
    Entregado el 12 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All property and undertaking of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 march 2001 and
    Creado el 03 nov 2000
    Entregado el 28 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and/or future obligations and liabilities of mwb hotel properties limited (the borrower) pursuant to the loan agreement between the borrower and hotel invest UK a/s and all liabilities of the company pursuant to this debenture and all liabilities of any group company to sas hotel management limited in respect of fees pursuant to hotel management agreements
    Breve descripción
    All and whole that area in the county midlothian with buildings thereon extending to 0.35 acres lying in tower place leith, all and whole 0.338 acres lying to the south of tower stret lane, leith.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hotel Invest UK a/S
    Transacciones
    • 28 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third party debenture
    Creado el 03 nov 2000
    Entregado el 22 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or mwb hotel properties limited under or pursuant to the loan agreement and all liabilities of the chargor pursuant to the debenture
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hotel Invest UK a/S
    Transacciones
    • 22 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 november 2000 and
    Creado el 03 nov 2000
    Entregado el 21 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities of mwb hotel properties limited (the "borrower") to the chargee under or pursuant to the financing documents (as defined) and all liabilities of the chargor pursuant to the standard security
    Breve descripción
    The subjects at tower place/tower street,leith lying in the county of midlothian with all buildings thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined in the Standardsecurity)
    Transacciones
    • 21 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third party debenture
    Creado el 03 nov 2000
    Entregado el 20 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of mwb hotel properties limited to the chargee under or pursuant to the financing documents (as defined) and all liabilities of the company pursuant to the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Societe Generale (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 20 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 march 1998 and
    Creado el 18 mar 1998
    Entregado el 09 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as therein defined)
    Breve descripción
    The malmaison hotel tower place/tower street leith edinburgh midlothian.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company(As Agent and Trustee of Itself and the Securedparties)
    Transacciones
    • 09 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of admission to composite guarantee indemnity and debenture
    Creado el 04 dic 1997
    Entregado el 22 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (to be renamed the malmaison company (edinburgh) limited) to the chargee in its capacity as agent and trustee for the secured parties (the security trustee) under or pursuant to the financing documents (as defined) including all its liabilities under clause 3 of the security (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 22 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0