WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03442017
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED?

    • (6210) /
    • (6220) /
    • (6323) /

    ¿Dónde se encuentra WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2007

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cuenta final antes de la disolución

    27 páginasWU15

    Domicilio social registrado cambiado de Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP a Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 01 nov 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador

    1 páginas4.31

    Orden del tribunal para liquidar

    COCOMP

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:court order replacement of liquidator
    10 páginasLIQ MISC OC

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    2 páginasRM02

    Orden del tribunal para liquidar

    COCOMP

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:court order - replacement of liquidator
    12 páginasLIQ MISC OC

    Nombramiento de un liquidador

    1 páginas4.31

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Pricewaterhousecoopers Llp Lennox House Spa Road Gloucester Gloucestershire GL1 1XD* el 11 jul 2011

    2 páginasAD01

    Orden del tribunal para liquidar

    1 páginasCOCOMP

    Domicilio social registrado cambiado de * Phantom House Siskin Parkway West Coventry Airport South Coventry CV3 4PB* el 04 ene 2010

    1 páginasAD01

    Orden del tribunal para liquidar

    1 páginasCOCOMP

    legacy

    6 páginasLQ01

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    21 páginasAA

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    legacy

    10 páginas363a

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MADDEN, Brian Joseph
    Leeson
    7 Well Road
    Douglas
    Cork
    Secretario
    Leeson
    7 Well Road
    Douglas
    Cork
    BritishFinance Director86486580002
    COUGHLIN, Timothy Gregory
    High Road
    Arbrack,
    Kinsale
    Fastnet House,
    Co.Cork
    Ireland
    Director
    High Road
    Arbrack,
    Kinsale
    Fastnet House,
    Co.Cork
    Ireland
    IrishProperty Developer134236070001
    COX, Brian Thomas
    Hilltown
    Carrigaline
    Mountlee
    Co Cork
    Ireland
    Director
    Hilltown
    Carrigaline
    Mountlee
    Co Cork
    Ireland
    IrishAirport Director134758790001
    MADDEN, Brian Joseph
    Leeson
    7 Well Road
    Douglas
    Cork
    Director
    Leeson
    7 Well Road
    Douglas
    Cork
    BritishFinance Director86486580002
    STIPANCIC, Charles
    Suite 240
    7600 Colshire Drive
    IRISH Mclean
    Virginia 22102
    United States
    Director
    Suite 240
    7600 Colshire Drive
    IRISH Mclean
    Virginia 22102
    United States
    AmericanOperations Management Of Aviat110149570001
    CRABTREE, Richard Anthony King
    Cypress Cottage Valley Road
    Finmere
    MK18 4AL Buckingham
    Buckinghamshire
    Secretario
    Cypress Cottage Valley Road
    Finmere
    MK18 4AL Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director15965170001
    GUYNAN, Stephen
    3 Albury Square
    The Park
    NG7 1AB Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    3 Albury Square
    The Park
    NG7 1AB Nottingham
    Nottinghamshire
    British75324050001
    MADDEN, Brian Joseph
    Outwoods
    Dorea Rathfeigh
    Tara
    County Meath
    Ireland
    Secretario
    Outwoods
    Dorea Rathfeigh
    Tara
    County Meath
    Ireland
    IrishAccountant86486580001
    RUSSELL, Angela
    22 Bishops Close
    EN5 2QH Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    22 Bishops Close
    EN5 2QH Barnet
    Hertfordshire
    British776080002
    WATERHOUSE, David John
    Fairholme
    Reeds Lane, Sayers Common
    BN6 9JG Hassocks
    West Sussex
    Secretario
    Fairholme
    Reeds Lane, Sayers Common
    BN6 9JG Hassocks
    West Sussex
    British73060140003
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Secretario designado corporativo
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    CHARNOCK, William Terence
    11 Burleigh Place
    Cambalt Road
    SW15 6ES London
    Director
    11 Burleigh Place
    Cambalt Road
    SW15 6ES London
    EnglandBritishDirector51990960001
    COLLETT, Michael John Hirst
    La Luisa
    Chemin De Moulin St Ouen
    JE3 2FL Jersey
    Channel Islands
    Director
    La Luisa
    Chemin De Moulin St Ouen
    JE3 2FL Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritishCompany Director77249840001
    COUGHLAN, Timothy Gregory
    3 Farm Drive
    Purley
    CR8 3LP Surrey
    Director
    3 Farm Drive
    Purley
    CR8 3LP Surrey
    IrishProperty Developer18206600001
    CRABTREE, Richard Anthony King
    Cypress Cottage Valley Road
    Finmere
    MK18 4AL Buckingham
    Buckinghamshire
    Director
    Cypress Cottage Valley Road
    Finmere
    MK18 4AL Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director15965170001
    FARRIN ROBINSON, Gail Carolyn
    Coxland Farm
    Cheriton Bishop
    EX6 6JU Exeter
    Devon
    Director
    Coxland Farm
    Cheriton Bishop
    EX6 6JU Exeter
    Devon
    BritishDirector44160570017
    FODEN, William James
    Lower Fosse
    Near Radford Semele
    CV31 1XJ Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    Lower Fosse
    Near Radford Semele
    CV31 1XJ Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishCommercial Pilot15143090001
    HUNTER, Alexander Geddes
    Park Blossom
    Peover Lane North Rode
    CW12 3QH Congleton
    Cheshire
    Director
    Park Blossom
    Peover Lane North Rode
    CW12 3QH Congleton
    Cheshire
    BritishAccountant78228870001
    JEPSON, Martin Clive
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    Director
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor92627900001
    JONES, Adrian Paul
    11 Glen Park Drive
    PR9 9FA Southport
    Merseyside
    Director
    11 Glen Park Drive
    PR9 9FA Southport
    Merseyside
    BritishFinancial Director96383640001
    LEONARD, Edward
    23 Av. Centrale
    St Jean Cap Ferrat
    06230
    Director
    23 Av. Centrale
    St Jean Cap Ferrat
    06230
    FranceBritishIt Consultant122987670002
    MADDEN, Brian Joseph
    Outwoods
    Dorea Rathfeigh
    Tara
    County Meath
    Ireland
    Director
    Outwoods
    Dorea Rathfeigh
    Tara
    County Meath
    Ireland
    IrelandIrishAccountant86486580001
    ORPHANOU, Christos Savvas
    96 Braemar Road
    KT4 8NW Worcester Park
    Director
    96 Braemar Road
    KT4 8NW Worcester Park
    EnglandBritishDirector112653120001
    REEVE, John Arthur
    8 Stocking Meadow
    Monks Kirby
    CV23 0RF Rugby
    Warwickshire
    Director
    8 Stocking Meadow
    Monks Kirby
    CV23 0RF Rugby
    Warwickshire
    BritishGeneral Manager62347920001
    ROBINSON, Alan Stuart Macdonald
    Coxland Farm
    Cheriton Bishop
    EX6 6JU Exeter
    Devon
    Director
    Coxland Farm
    Cheriton Bishop
    EX6 6JU Exeter
    Devon
    BritishDirector94679630005
    SAVAGE, William Henry
    Church Farm
    Llangwm
    NP15 1HA Usk
    Monmouthshire
    Director
    Church Farm
    Llangwm
    NP15 1HA Usk
    Monmouthshire
    WalesBritishManaging Director97249160001
    WAGGOTT, William Harrison
    The Five Bells
    Tylers Hill Road
    HP5 1XJ Botley
    Buckinghamshire
    Director
    The Five Bells
    Tylers Hill Road
    HP5 1XJ Botley
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director79357940001

    ¿Tiene WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 ene 2006
    Entregado el 01 feb 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 01 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 105 dic 2009Nombramiento de un receptor o gerente (LQ01)
    • 129 oct 2013Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 1
    Legal charge
    Creado el 26 feb 2003
    Entregado el 06 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The homestead stoneleigh road baginton coventry CV8 3BA. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland International Limited (Trading as Nat West)
    Transacciones
    • 06 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 15 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 feb 2002
    Entregado el 19 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transacciones
    • 19 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WEST MIDLANDS INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gregory Bill Judd
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    Administrador judicial/gestor
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    Simon James Hunt
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    Administrador judicial/gestor
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    2
    FechaTipo
    21 jun 2018Conclusión de la liquidación
    23 oct 2009Fecha de la petición
    09 dic 2009Inicio de la liquidación
    13 dic 2018Fecha de disolución
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Profesional
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Edward Williams
    Lennox House Spa Road
    GL1 1XD Gloucester
    Gloucestershire
    Profesional
    Lennox House Spa Road
    GL1 1XD Gloucester
    Gloucestershire
    Stuart David Maddison
    Lennox House Spa Road
    GL1 1XD Gloucester
    Gloucestershire
    Profesional
    Lennox House Spa Road
    GL1 1XD Gloucester
    Gloucestershire
    Mark David Charles Hopkins
    Lennox House Spa Road
    GL1 1XD Gloucester
    Gloucestershire
    Profesional
    Lennox House Spa Road
    GL1 1XD Gloucester
    Gloucestershire
    Julian Guy Parr
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0