SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03446439 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
- Evaluación de riesgos y daños (66210) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ORIEL SERVICES LIMITED | 27 mar 2008 | 27 mar 2008 |
| CUNNINGHAM LINDSEY PROPERTY SOLUTIONS LIMITED | 02 abr 2001 | 02 abr 2001 |
| ELLIS & BUCKLE PROPERTY SOLUTIONS LIMITED | 19 ene 1998 | 19 ene 1998 |
| LAW 891 LIMITED | 08 oct 1997 | 08 oct 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 29 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 29 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Gibson el 01 ago 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Sedgwick International Uk en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 may 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 30 páginas | AA | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 60 Fenchurch Street London EC3M 4AD England a 30 Fenchurch Street London EC3M 3BD el 16 may 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sahil Nath Rishi como director el 24 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 18 nov 2022
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Sahil Nath Rishi como director el 09 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 24 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2022 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 26 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Keith Christopher Walters como director el 04 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sahil Nath Rishi como director el 04 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Edward Jenner como director el 04 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON, Neil | Director | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 295432970001 | |||||||||
| WALTERS, Keith Christopher | Director | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | United Kingdom | British | 295507030001 | |||||||||
| WASSELL, Peter Andrew | Director | Fenchurch Street EC3M 3BD London 30 England | England | British | 295433170001 | |||||||||
| BRUCE, David Julian | Secretario | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England | 162309960001 | |||||||||||
| JENNER, John Edward | Secretario | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | Irish | 66166470002 | ||||||||||
| PANTING, Jeffrey | Secretario | 16 Hurford Drive RG19 4WA Thatcham Berkshire | British | 57074560001 | ||||||||||
| SUTTON, Jonathan | Secretario | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | 215545680001 | |||||||||||
| BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
| CORPORATION SERVICE COMPANY (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Canada Square E14 5LQ London 25 England |
| 216788570001 | ||||||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 | |||||||||||
| BALL, Geoff | Director | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | England | British | 127514000001 | |||||||||
| BRUCE, David Julian | Director | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England | United Kingdom | British | 110877530002 | |||||||||
| CLUTTERBUCK, Adam | Director | 148 South Park Road Wimbledon SW19 8TA London | British | 57586610004 | ||||||||||
| DAVIS, Paul Woodall | Director | 301 Meadowfield Bluff Road FL Yulee Usa | American | 57586630001 | ||||||||||
| DI CICCO, Domenick C. | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | United States | American | 207059350001 | |||||||||
| HENDERSON, Mark | Director | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | United Kingdom | British | 83178710001 | |||||||||
| JENNER, John Edward | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | Irish | 183383870001 | |||||||||
| JENNER, John Edward | Director | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | United Kingdom | Irish | 66166470002 | |||||||||
| LOUGHNEY, Gerard Anthony | Director | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | England | British | 6751240002 | |||||||||
| ODEDRA, Meera | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 207219690001 | |||||||||
| PIGOT, David Kearsley | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 144137620001 | |||||||||
| RAPER, Stephen | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 259503170001 | |||||||||
| RISHI, Sahil Nath | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 187737090003 | |||||||||
| RISHI, Sahil Nath | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 187737090003 | |||||||||
| SINCLAIR, David | Director | 9 Longbridge Willesborough Lees TN24 0TA Ashford Kent | England | British | 85396320001 | |||||||||
| SOUTAR, Alan James Wilson | Director | Shaker House 4 The Downs CM6 1DS Great Dunmow Essex | United Kingdom | British | 165113740001 | |||||||||
| SPRING-BENYON, Nigel Ernest John | Director | 5 Wayland Heights BN1 5RA Brighton East Sussex | British | 56064230002 | ||||||||||
| STEEL, Stewart Craig | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 137619350001 | |||||||||
| SUTTON, Jonathan Guy | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | England | British | 215482550001 | |||||||||
| TUBB, Elizabeth Janet Mary | Director | Cunningham Lindsey Apex Plaza, Forbury Road RG1 1AX Reading 1 Berkshire | United Kingdom | British | 162278590001 | |||||||||
| WALKER, Peter | Director | 19 Bridleways BH31 6LA Verwood Dorset | British | 70534950001 | ||||||||||
| WHITE, Paul | Director | Fenchurch Street EC3M 4AD London 60 England | Scotland | British | 264968770001 | |||||||||
| WRIGHT, Paul | Director | Gascoigne Farm High Halden TN26 3JJ Ashford Kent | England | British | 73155000002 | |||||||||
| HUNTSMOOR LIMITED | Director designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008150001 | |||||||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SEDGWICK REPAIR SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedgwick International Uk | 06 abr 2016 | Fenchurch Street EC3M 3BD London Sedgwick, 30 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0