CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03446491 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED?
Dirección de la sede social | Wellington House Cliffe Park LS27 0RY Bruntcliffe Road Morley Leeds West Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
LAW 905 LIMITED | 08 oct 1997 | 08 oct 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 01 ene 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Manish Mansukhlal Gudka como director el 27 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Don Goulding como secretario el 27 sept 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Edward Purtill como director el 27 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Don Goulding como director el 27 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gareth Jones como director el 27 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 ene 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 ene 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ian Don Goulding el 12 feb 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ian Don Goulding el 12 feb 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 ene 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Ian Don Goulding el 30 ago 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ian Don Goulding el 30 ago 2012 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUDKA, Manish Mansukhlal | Director | Balderton Street W1K 6TL London 20 England | United Kingdom | British | Company Director | 163227370001 | ||||
JONES, Gareth | Director | Balderton Street W1K 6TL London 20 England | England | British | Chartered Accountant | 121225470001 | ||||
GOULDING, Ian Don | Secretario | Scotgate Road Honley HD9 6RE Holmfirth 4 St David's Court England | British | Director | 39828490004 | |||||
HENLEY, John David | Secretario | 16 Broomfield Ride Oxshott KT22 0LW Leatherhead Surrey | British | Director | 50850350001 | |||||
KINGSTON, Mark Andrew | Secretario | Whitehall Farm Brissenden Green TN26 3BJ Bethersden Kent | British | Accountant | 47452060001 | |||||
HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 | |||||||
DUKES, Rodney | Director | 64 Copsewood Way HA6 2UA Northwood Middlesex | British | Solicitor | 57012310001 | |||||
GOULDING, Ian Don | Director | Scotgate Road Honley HD9 6RE Holmfirth 4 St David's Court England | England | British | Director | 39828490044 | ||||
HENLEY, John David | Director | 16 Broomfield Ride Oxshott KT22 0LW Leatherhead Surrey | England | British | Director | 50850350001 | ||||
KINGSTON, Mark Andrew | Director | Whitehall Farm Brissenden Green TN26 3BJ Bethersden Kent | British | Accountant | 47452060001 | |||||
LEWIS, Carl Alexander | Director | Badgers Croft Caldy Wood Caldy CH48 2LT Wirral Merseyside | United Kingdom | British | Director | 52633210001 | ||||
PURTILL, Michael Edward | Director | Froghall Barmby Moor YO42 4DA Pocklington East Yorkshire | England | Irish | Director | 7856280001 | ||||
SCRAGG, Christopher David | Director | Blackhurst Hall Blackhurst Park Halls Hole Road TN2 4RG Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Hotelier | 27676690004 | ||||
TAYLOR, David James | Director | 18 Spencers Way HG1 3DN Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 88020060001 | ||||
HUNTSMOOR LIMITED | Director designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008150001 | |||||||
HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marston Hotels Limited | 25 ene 2017 | Cliffe Park Way, Bruntcliffe Road Morley LS27 0RY Leeds Wellington House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Devonshire Point Investment S.A.R.L | 25 ene 2017 | Rue Lou Hemmer L-1748 Findel 4 Luxembourg | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CHESHIRE COUNTRY HOTELS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 31 ene 2003 Entregado el 14 feb 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 08 mar 2000 Entregado el 11 mar 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hproperty k/a crabwell manor hotel parkgate road blacon-cum-crabwell mollington cheshire together with all plant machinery all rights in intellectual property goodwill uncalled capital all present and future rights title and interest in security all bills of exchange promissory notes and negotiable instruments all debts contracts or policies of insurance. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 22 ene 1998 Entregado el 27 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All right title estate and other interest in crabwell hall hotel parkgate road blacon-cum-crabwell mollington cheshire (also k/a crabwell manor hotel) t/n CH251304. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0