GOOD INFLUENCE LIMITED

GOOD INFLUENCE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGOOD INFLUENCE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03449094
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GOOD INFLUENCE LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra GOOD INFLUENCE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    PO BOX 70693 62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GOOD INFLUENCE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    1B COMMUNICATIONS LIMITED22 jun 201222 jun 2012
    DE FACTO COMMUNICATIONS LIMITED30 mar 200530 mar 2005
    DE FACTO COMMUNICATIONS PLC30 jul 200330 jul 2003
    H.C.C. DE FACTO GROUP PLC08 oct 199708 oct 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GOOD INFLUENCE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GOOD INFLUENCE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    5 páginasAA

    Cancelación total de la carga 5

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    3 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name07 may 2019

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 07 may 2019

    RES15

    Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Comptes modifiés d'exonération totale établis au 31 dic 2017

    10 páginasAAMD

    legacy

    80 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr David Crowther como director el 31 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Fiona Mary Sharp como director el 31 dic 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 17 oct 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Fiona Mary Sharp el 01 oct 2017

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de un secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Robert Edward Davison como secretario el 31 mar 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Robert Edward Davison como director el 31 mar 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 17 oct 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de PO Box 70693 Southside 105 Victoria Street London SW1P 9ZP a PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP el 18 feb 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 oct 2015

    Estado de capital el 12 oct 2015

    • Capital: GBP 105,703.2
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de GOOD INFLUENCE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CROWTHER, David
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Director
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritish184391050001
    CHARLES, Susan Jane
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    Secretario
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    British40366110001
    CONINGTON, Mary Denise
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    Secretario
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    British39416550001
    DAVISON, Robert Edward
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Secretario
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    British175283600001
    DAVISON, Robert Edward
    Yeomans Close
    Thorley Park
    CM23 4EU Bishops Stortford
    23
    Hertfordshire
    Secretario
    Yeomans Close
    Thorley Park
    CM23 4EU Bishops Stortford
    23
    Hertfordshire
    British45449440002
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secretario designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EVERITT, David Anthony
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    Secretario
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    British33752810001
    TOLLISS, Thomas George
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    United Kingdom
    Secretario
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    United Kingdom
    British165540160001
    ANDERSON, Richard James
    The White Cottage
    4 Thornton Road
    SW19 4NB Wimbledon
    Director
    The White Cottage
    4 Thornton Road
    SW19 4NB Wimbledon
    British39416370003
    CHAPMAN, Simon Charles, Dr
    15 Westminster Gardens
    SW1P 4JA London
    Director
    15 Westminster Gardens
    SW1P 4JA London
    British119295110001
    CHARLES, Susan Jane
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    Director
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    British40366110001
    CONINGTON, Paul Edward Martin
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    Director
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    United KingdomBritish141476280002
    DAVISON, Robert Edward
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Director
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritish45449440002
    DIBLE, David James
    Church House
    118 Trinity Road
    EH5 3LA Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Church House
    118 Trinity Road
    EH5 3LA Edinburgh
    Midlothian
    British72447220001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Director designado
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Director designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EVERITT, David Anthony
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    Director
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    British33752810001
    HAYHURST, Richard Frank
    19 Riverdale Gardens
    TW1 2BX East Twickenham
    Middlesex
    Director
    19 Riverdale Gardens
    TW1 2BX East Twickenham
    Middlesex
    British15866330003
    KIDDY, Christine Susan
    2 Regents Gate
    Sarisbury Green
    SO31 7LB Southampton
    Hampshire
    Director
    2 Regents Gate
    Sarisbury Green
    SO31 7LB Southampton
    Hampshire
    British86197080001
    LEECE, John Henry
    12 Mayfield Road
    Wimbledon
    SW19 3NF London
    Director
    12 Mayfield Road
    Wimbledon
    SW19 3NF London
    United KingdomBritish10904170002
    MAHON, Michaela
    2 Righton Close
    Charvil
    RG10 9UN Twyford
    Berkshire
    Director
    2 Righton Close
    Charvil
    RG10 9UN Twyford
    Berkshire
    British79001260001
    PAYNE, Kevin Jacques
    Culmer Corner
    Culmer Lane
    GU8 5SP Wormley
    Surrey
    Director
    Culmer Corner
    Culmer Lane
    GU8 5SP Wormley
    Surrey
    British40366170001
    SANDEMAN, Diane Elizabeth
    17 Ravel Close
    Brighton Hill
    RG22 4EB Basingstoke
    Hampshire
    Director
    17 Ravel Close
    Brighton Hill
    RG22 4EB Basingstoke
    Hampshire
    British48719120001
    SHARP, Fiona Mary
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Director
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritish66457680002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GOOD INFLUENCE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England
    England
    06 abr 2016
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1983857
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene GOOD INFLUENCE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 ago 2012
    Entregado el 29 ago 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 06 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 31 mar 2006
    Entregado el 07 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 06 jun 2002
    Entregado el 11 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company with full title guarantee charges £16,000.00 to the chargee.
    Personas con derecho
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transacciones
    • 11 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 26 ene 2001
    Entregado el 30 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed
    Breve descripción
    £16,000.
    Personas con derecho
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transacciones
    • 30 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 18 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 ene 1999
    Entregado el 02 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 02 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 19 jun 1998
    Entregado el 23 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined within
    Breve descripción
    The initial deposit of £41,750 and all other monies relative thereto ( the "deposit balance").
    Personas con derecho
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transacciones
    • 23 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 03 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0