CAPARO ENGINEERING LIMITED

CAPARO ENGINEERING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCAPARO ENGINEERING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03450375
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    • fundición de hierro (24510) / Industrias manufactureras
    • fundición de otros metales no ferrosos (24540) / Industrias manufactureras
    • fabricación de otros productos de metal n.c.o.p. (25990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SUPREMO 2000 LIMITED15 oct 199715 oct 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    23 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 oct 2023

    23 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 oct 2022

    22 páginasLIQ03

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secreatary of state release of liquidator.
    1 páginasLIQ MISC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 oct 2021

    23 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    15 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    13 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 oct 2020

    24 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 oct 2019

    25 páginasLIQ03

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 páginasLIQ MISC

    Destitución del liquidador por orden judicial

    17 páginasLIQ10

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    34 páginasAM22

    Informe de progreso del administrador

    32 páginasAM10

    Domicilio social registrado cambiado de 7 More London Riverside London SE1 2RT a Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL el 07 oct 2017

    2 páginasAD01

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    29 páginasAM10

    Aviso de renuncia de un administrador

    11 páginas2.38B

    Informe de progreso del administrador hasta 18 oct 2016

    27 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Resultado de la reunión de acreedores

    1 páginas2.23B

    Informe de progreso del administrador hasta 18 abr 2016

    32 páginas2.24B

    Cese del nombramiento de Derek Michael O'reilly como director el 17 dic 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Director
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited KingdomCompany Director130813310001
    BENNETT, Paul Richard
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    Secretario
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    British76951010001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Secretario designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Secretario
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    BritishAccountant126516810001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director56051330001
    BEATON, Kevin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritishDirector150211630001
    BOTTING, Richard Graham
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    Director
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    BritishDirector85897150001
    BUTLER, Richard Gareth John
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritishDirector117859680001
    CLIFF, Richard Martyn
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    Director
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector56113440001
    CURRAN, James Thomas
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    Director
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    United KingdomBritishManaging Director56844020001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Director
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritishCompany Director55380530001
    GANE, Christopher Nigel
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    ScotlandBritishDirector73268030001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Director designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HAMMOND, Christopher Mark
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritishDirector60992860002
    HARTLAND, Melvyn Edward
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    Director
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    BritishManaging Director8436920002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Director
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritishDirector108440160002
    PAUL, Akhil
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritishDirector199010800001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Director
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector92729600003
    PAY, Jason Christopher
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritishDirector126516810001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Director
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant126516810001
    PINCHES, Brian Michael
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    BritishManaging Director44065140001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director56051330001
    TAYLOR, Paul
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    Director
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director49786260004
    UNDERHILL, Maurice
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    Director
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    BritishManaging Director12842580001
    WHALE, Ian
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritishDirector192902390001
    WOOD, John Franklin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Director
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritishDirector1397720001
    WOOD, John Franklin
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    Director
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector1397720001

    ¿Tiene CAPARO ENGINEERING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 feb 2014
    Entregado el 13 mar 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Caparo PLC
    Transacciones
    • 13 mar 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 15 jul 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    F/H property. Caparo testing, brenda road, hartlepool t/no CE52039.. Caparo forgoing, marriott road, dudley t/no WM383778. (For details of patents charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Transacciones
    • 15 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 05 jul 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    F/H land at caparo testing brenda road hartlepool t/no CE52039. F/h land at caparo forging marriott road dudley t/no WM383778. Patent described as "mounting (cmt own shock absorber)" filed in 1998 with number GB2330642. For details of further intellectual property please refer to deed. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 05 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    Polish law registered pledge agreement
    Creado el 19 ago 2011
    Entregado el 25 ago 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000 (say: fifty million zlotys), all the rights. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Caparo PLC
    Transacciones
    • 25 ago 2011Registro de un cargo (MG01)
    Polish law registered pledge agreement
    Creado el 19 ago 2011
    Entregado el 25 ago 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000 (say: ten million euro), all the rights. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Jalia Holding S.A.
    Transacciones
    • 25 ago 2011Registro de un cargo (MG01)
    Pledge agreement
    Creado el 30 nov 2010
    Entregado el 10 dic 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000.
    Personas con derecho
    • Caparo PLC
    Transacciones
    • 10 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    Pledge agreement
    Creado el 26 nov 2010
    Entregado el 10 dic 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000.
    Personas con derecho
    • Jalia Holding Sa
    Transacciones
    • 10 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    Security agreement
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 06 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Creado el 31 ene 2002
    Entregado el 14 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    (I) fixed equitable charge any debt (as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever including the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 03 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene CAPARO ENGINEERING LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 oct 2015Inicio de la administración
    26 oct 2018Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    2
    FechaTipo
    21 may 2024Fecha prevista de disolución
    26 oct 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Edward Williams
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0