GATEWAY OFFSITE LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGATEWAY OFFSITE LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03453040
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GATEWAY OFFSITE LTD?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra GATEWAY OFFSITE LTD?

    Dirección de la sede social
    Unicorn House Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GATEWAY OFFSITE LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BRITSPACE HOTELS LIMITED09 dic 200809 dic 2008
    GATEWAY FABRICATIONS LIMITED29 dic 199729 dic 1997
    TALKTOP LIMITED21 oct 199721 oct 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GATEWAY OFFSITE LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GATEWAY OFFSITE LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Matthew Cowan como secretario el 30 sept 2011

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Ian Sherriff como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Matthew Cowan como secretario

    1 páginasAP03

    Domicilio social registrado cambiado de Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR United Kingdom el 28 jun 2011

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Unicorn House Broad Lane Gilberdyke Brough East Yorkshire HU15 2TS el 27 jun 2011

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de James Bradney como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Christopher Harris como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Terence Jackson como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de James Bradney como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Christopher John Huckle como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 21 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 oct 2010

    Estado de capital el 26 oct 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr Ian Sherriff como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Stephen Clarke como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    12 páginasAA

    legacy

    11 páginasMG01

    legacy

    5 páginasMG01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de GATEWAY OFFSITE LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARRIS, David Christopher
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish76088090001
    HUCKLE, Christopher John
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141831160001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Secretario
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    British63261140001
    CLARKE, Stephen
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Secretario
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    British122285190001
    COWAN, Matthew
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    161230490001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Secretario
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    British19792670001
    HORNCASTLE, Carole Diane
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    Secretario
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    British79178970001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Secretario
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Secretario
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SHERRIFF, Ian
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    Secretario
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    149407420001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Secretario
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, Stewart Martin
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    Director
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish100469640001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Director
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Director
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BEALES, Stuart Patrick
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    Director
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    United KingdomBritish136886810001
    BRADNEY, James
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Director
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish161101450001
    CLARK, William Angus
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    Director
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    British80223540001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Director
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish19792670001
    HARRIS, David Christopher
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    Director
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish76088090001
    HORNCASTLE, Andrew Nigel
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    Director
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish4456360002
    JACKSON, Terence William
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    Director
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    UkBritish132410210001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Director
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Director
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SCANLAN, Sarah Rebecca
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    Director
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    British55408650001
    TAYLOR, Malcolm
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    Director
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    EnglandBritish83888440001
    TREBBLE, Stephen Paul
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    Director
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    EnglandBritish76640730001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Director
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene GATEWAY OFFSITE LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 16 nov 2009
    Entregado el 20 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 08 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 16 nov 2009
    Entregado el 20 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 08 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 06 nov 2009
    Entregado el 18 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Nvm Private Equity Limited
    Transacciones
    • 18 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 08 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 03 oct 2008
    Entregado el 18 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Nvm Private Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transacciones
    • 18 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 sept 2002
    Entregado el 19 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Northern Venture Managers Limited
    Transacciones
    • 19 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 12 sept 2002
    Entregado el 19 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the company and by any other company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 mar 2000
    Entregado el 17 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 31 mar 2000
    Entregado el 06 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Horncastle Group PLC
    Transacciones
    • 06 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0