LENDLEASE SOLIHULL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LENDLEASE SOLIHULL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03458451 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?
| Dirección de la sede social | 20 Triton Street Regent's Place NW1 3BF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LEND LEASE SOLIHULL LIMITED | 23 abr 1998 | 23 abr 1998 |
| LEND LEASE TURIN LIMITED | 23 dic 1997 | 23 dic 1997 |
| HACKREMCO (NO.1288) LIMITED | 31 oct 1997 | 31 oct 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Victoria Elizabeth Quinlan como director el 09 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2017 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2016 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Draper como secretario el 21 dic 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Thomas Lachlan Mackellar como director el 20 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark John Packer como director el 20 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Jennifer Draper como secretario el 20 oct 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Capita Company Secretarial Services Limited como secretario el 28 ago 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Andrew Coppell como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 20 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Capita Company Secretarial Services Limited el 30 oct 2014 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACKELLAR, Thomas Lachlan | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | England | Australian | 211753840001 | |||||||||
| PACKER, Mark John | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | United Kingdom | British | 192191690001 | |||||||||
| CUTTS, Alistair | Secretario | 15a Vine Road KT8 9LF East Molesey Surrey | British | 103721920002 | ||||||||||
| DAVIDSON, Patricia Margaret | Secretario | 39 Saunderton Vale Saunderton HP14 4LJ High Wycombe Buckinghamshire | British | 38824170008 | ||||||||||
| DRAPER, Jennifer | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 | 216757260001 | |||||||||||
| GOUGH, Alison Louise | Secretario | 12 Redcliffe Mews SW10 9JU London | Australian | 62074540001 | ||||||||||
| JANANDRAN, Thanalakshmi | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | British | 93299990001 | ||||||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Secretario | 36 Vicarage Road RG9 1HW Henley On Thames Oxfordshire | British | 92464400001 | ||||||||||
| NICKLIN, Susan Patricia | Secretario | Flat 4 7 Barkston Gardens SW5 0ER Earls Court London | British | 88285310001 | ||||||||||
| SUTTON, Penelope Ruth | Secretario | 32 Saxon Road BR1 3RP Bromley Kent | British | 38586070002 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Dukes Place EC3A 7NH London 40 England |
| 102944500001 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| ARTHUR, Derryn Sue | Director | 21 Elsham Road W14 8HA London | New Zealander | 57726590002 | ||||||||||
| BUTLER, Robin Elliot | Director | Gatehouse Farm GU31 5DB Trotton West Sussex | British | 90075620001 | ||||||||||
| CABLE, Richard Malcolm | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | British | 65264230002 | |||||||||
| CAVEN, Robin Graham | Director | 74 St Johns Road TN13 3NB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 76216840002 | |||||||||
| CHISHOLM, Allan Donald | Director | 49 Colcokes Road SM7 2EJ Banstead Surrey | England | British | 545510001 | |||||||||
| COLLINS, Jeremy David Marven | Director | Meridon House Bishops Sutton SO24 0AL Alresford Hampshire | United Kingdom | British | 85787750001 | |||||||||
| COPPELL, Richard Andrew | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 140027550001 | |||||||||
| GOUGH, Alison Louise | Director | Flat 1 15 Southwood Avenue N6 5RY London | British | 62074540002 | ||||||||||
| HUTTON, David Stewart | Director | 2-138 Fellows Road Swiss Cottage NW3 3JH London | Australian | 70960410002 | ||||||||||
| LABBAD, Daniel | Director | Lenthall Road E8 3JN London 107, England | England | Australian | 111679880003 | |||||||||
| MARSHALL, Ian | Director | 43 Belsize Road NW6 4RX London | British | 81232950001 | ||||||||||
| MATHESON, Craig Stephen | Director | 5 Cook Court 151a Rotherhithe Street SE16 5QR London | United Kingdom | New Zealand | 96577080003 | |||||||||
| MATHESON, Craig Stephen | Director | 5 Cook Court 151a Rotherhithe Street SE16 5QR London | United Kingdom | New Zealand | 96577080003 | |||||||||
| NICKLIN, Digby Stuart | Director | Petworth Road Wisborough Green RH14 0BJ North Billingshurst Vine Cottage West Sussex | United Kingdom | British | 258960010001 | |||||||||
| PEERS, Jeffrey Nicholas | Director | 9 Eastbury Road KT2 5AL Kingston Upon Thames Surrey | Australian | 104800370001 | ||||||||||
| PERRY, David Keith | Director | Saint Leonards Road KT6 4DE Surbiton 10 Surrey | England | British | 71558970002 | |||||||||
| QUINLAN, Victoria Elizabeth | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 20 United Kingdom | England | Australian | 134667530006 | |||||||||
| SCOTT, Georgina Jane | Director | The Red House 49-53 Clerkenwell Road EC1M 5RS London Flat 10 | England | British | 129107550001 | |||||||||
| WALICHNOWSKI, Peter | Director | 7 York Avenue East Sheen SW14 7LQ London | Australian | 71829150001 | ||||||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendlease Europe Limited | 06 abr 2016 | Regent's Place NW1 3BF London 20 Triton Street England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LENDLEASE SOLIHULL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed | Creado el 14 ago 2001 Entregado el 21 ago 2001 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with the provisions of clause 9.4 of the agreement for lease dated 8TH august 2001 between the company (as developer) mexx limited (as tenant) and mexx group bv under which the developer agreed to grant and the tenant agreed to accept a lease of unit 9 touchwood solihull | |
Breve descripción All the company's right title benefit and interest in and to the deposit sum of £587,500 and all related rights accruing therefrom under the terms of the charge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 25 jun 1999 Entregado el 09 jul 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada In relation to a debtor all present and future obligations and liabilities due or to become due from that debtor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under or in relation to the eligible receivable (as defined) owned by it and in relation to a sale party all present and future obligations and liabilities due or to become from that sale party (as defined) or by some other person of that sale party to the purchase parties (as defined) (or any of them) under the purchase documents (as defined) on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H land k/a clarendon house solihull west midlands. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0