LENDLEASE SOLIHULL LIMITED

LENDLEASE SOLIHULL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLENDLEASE SOLIHULL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03458451
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    20 Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEND LEASE SOLIHULL LIMITED23 abr 199823 abr 1998
    LEND LEASE TURIN LIMITED23 dic 199723 dic 1997
    HACKREMCO (NO.1288) LIMITED31 oct 199731 oct 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Victoria Elizabeth Quinlan como director el 09 may 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2017

    13 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2016

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jennifer Draper como secretario el 21 dic 2016

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Thomas Lachlan Mackellar como director el 20 oct 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mark John Packer como director el 20 oct 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Jennifer Draper como secretario el 20 oct 2016

    2 páginasAP03

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name01 jul 2016

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 01 jul 2016

    RES15

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 nov 2015

    Estado de capital el 26 nov 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Capita Company Secretarial Services Limited como secretario el 28 ago 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Richard Andrew Coppell como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 nov 2014

    Estado de capital el 03 nov 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 20 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF

    1 páginasAD04

    Cambio de datos del secretario Capita Company Secretarial Services Limited el 30 oct 2014

    1 páginasCH04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    12 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    ¿Quiénes son los directivos de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MACKELLAR, Thomas Lachlan
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    Director
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    EnglandAustralian211753840001
    PACKER, Mark John
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    Director
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United KingdomBritish192191690001
    CUTTS, Alistair
    15a Vine Road
    KT8 9LF East Molesey
    Surrey
    Secretario
    15a Vine Road
    KT8 9LF East Molesey
    Surrey
    British103721920002
    DAVIDSON, Patricia Margaret
    39 Saunderton Vale
    Saunderton
    HP14 4LJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    39 Saunderton Vale
    Saunderton
    HP14 4LJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British38824170008
    DRAPER, Jennifer
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    Secretario
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    216757260001
    GOUGH, Alison Louise
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Secretario
    12 Redcliffe Mews
    SW10 9JU London
    Australian62074540001
    JANANDRAN, Thanalakshmi
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    Secretario
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    British93299990001
    MARTIN, Neil Christopher
    36 Vicarage Road
    RG9 1HW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    36 Vicarage Road
    RG9 1HW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British92464400001
    NICKLIN, Susan Patricia
    Flat 4
    7 Barkston Gardens
    SW5 0ER Earls Court
    London
    Secretario
    Flat 4
    7 Barkston Gardens
    SW5 0ER Earls Court
    London
    British88285310001
    SUTTON, Penelope Ruth
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    Secretario
    32 Saxon Road
    BR1 3RP Bromley
    Kent
    British38586070002
    CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Dukes Place
    EC3A 7NH London
    40
    England
    Secretario corporativo
    Dukes Place
    EC3A 7NH London
    40
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro05306796
    102944500001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secretario designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ARTHUR, Derryn Sue
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    Director
    21 Elsham Road
    W14 8HA London
    New Zealander57726590002
    BUTLER, Robin Elliot
    Gatehouse Farm
    GU31 5DB Trotton
    West Sussex
    Director
    Gatehouse Farm
    GU31 5DB Trotton
    West Sussex
    British90075620001
    CABLE, Richard Malcolm
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    Director
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish65264230002
    CAVEN, Robin Graham
    74 St Johns Road
    TN13 3NB Sevenoaks
    Kent
    Director
    74 St Johns Road
    TN13 3NB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish76216840002
    CHISHOLM, Allan Donald
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    Director
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    EnglandBritish545510001
    COLLINS, Jeremy David Marven
    Meridon House
    Bishops Sutton
    SO24 0AL Alresford
    Hampshire
    Director
    Meridon House
    Bishops Sutton
    SO24 0AL Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish85787750001
    COPPELL, Richard Andrew
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    Director
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish140027550001
    GOUGH, Alison Louise
    Flat 1 15 Southwood Avenue
    N6 5RY London
    Director
    Flat 1 15 Southwood Avenue
    N6 5RY London
    British62074540002
    HUTTON, David Stewart
    2-138 Fellows Road
    Swiss Cottage
    NW3 3JH London
    Director
    2-138 Fellows Road
    Swiss Cottage
    NW3 3JH London
    Australian70960410002
    LABBAD, Daniel
    Lenthall Road
    E8 3JN London
    107,
    England
    Director
    Lenthall Road
    E8 3JN London
    107,
    England
    EnglandAustralian111679880003
    MARSHALL, Ian
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    Director
    43 Belsize Road
    NW6 4RX London
    British81232950001
    MATHESON, Craig Stephen
    5 Cook Court
    151a Rotherhithe Street
    SE16 5QR London
    Director
    5 Cook Court
    151a Rotherhithe Street
    SE16 5QR London
    United KingdomNew Zealand96577080003
    MATHESON, Craig Stephen
    5 Cook Court
    151a Rotherhithe Street
    SE16 5QR London
    Director
    5 Cook Court
    151a Rotherhithe Street
    SE16 5QR London
    United KingdomNew Zealand96577080003
    NICKLIN, Digby Stuart
    Petworth Road
    Wisborough Green
    RH14 0BJ North Billingshurst
    Vine Cottage
    West Sussex
    Director
    Petworth Road
    Wisborough Green
    RH14 0BJ North Billingshurst
    Vine Cottage
    West Sussex
    United KingdomBritish258960010001
    PEERS, Jeffrey Nicholas
    9 Eastbury Road
    KT2 5AL Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    9 Eastbury Road
    KT2 5AL Kingston Upon Thames
    Surrey
    Australian104800370001
    PERRY, David Keith
    Saint Leonards Road
    KT6 4DE Surbiton
    10
    Surrey
    Director
    Saint Leonards Road
    KT6 4DE Surbiton
    10
    Surrey
    EnglandBritish71558970002
    QUINLAN, Victoria Elizabeth
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    Director
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20
    United Kingdom
    EnglandAustralian134667530006
    SCOTT, Georgina Jane
    The Red House
    49-53 Clerkenwell Road
    EC1M 5RS London
    Flat 10
    Director
    The Red House
    49-53 Clerkenwell Road
    EC1M 5RS London
    Flat 10
    EnglandBritish129107550001
    WALICHNOWSKI, Peter
    7 York Avenue
    East Sheen
    SW14 7LQ London
    Director
    7 York Avenue
    East Sheen
    SW14 7LQ London
    Australian71829150001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Director designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LENDLEASE SOLIHULL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20 Triton Street
    England
    06 abr 2016
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    20 Triton Street
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03196202
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene LENDLEASE SOLIHULL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed
    Creado el 14 ago 2001
    Entregado el 21 ago 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with the provisions of clause 9.4 of the agreement for lease dated 8TH august 2001 between the company (as developer) mexx limited (as tenant) and mexx group bv under which the developer agreed to grant and the tenant agreed to accept a lease of unit 9 touchwood solihull
    Breve descripción
    All the company's right title benefit and interest in and to the deposit sum of £587,500 and all related rights accruing therefrom under the terms of the charge.
    Personas con derecho
    • Mexx Limted
    Transacciones
    • 21 ago 2001Registro de un cargo (395)
    Charge
    Creado el 25 jun 1999
    Entregado el 09 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In relation to a debtor all present and future obligations and liabilities due or to become due from that debtor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under or in relation to the eligible receivable (as defined) owned by it and in relation to a sale party all present and future obligations and liabilities due or to become from that sale party (as defined) or by some other person of that sale party to the purchase parties (as defined) (or any of them) under the purchase documents (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land k/a clarendon house solihull west midlands. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Private Bank and Trust Limited as Trustee for Each of the Beneficiaries (As Defined)Under the Receivables Trust Deed
    Transacciones
    • 09 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 07 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0