TM GROUP HOLDINGS LIMITED

TM GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTM GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03462566
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
    8th Floor, Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TM GROUP HOLDINGS PLC01 may 199801 may 1998
    ARROWFLEET PLC07 nov 199707 nov 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 may 2022
    Próximas cuentas vencen el24 may 2023
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 nov 2020

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta11 oct 2023
    Próxima declaración de confirmación vence25 oct 2023
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta11 oct 2022
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 may 2024

    27 páginasLIQ03

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 26 may 2023

    LRESEX

    Domicilio social registrado cambiado de , Ground Floor West One London Road, Brentwood, Essex, CM14 4QW, England a 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 08 jun 2023

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos

    14 páginasLIQ02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 may 2022 au 30 may 2022

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 11 oct 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 nov 2021 au 31 may 2022

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Chief Operating Officer Karen Anita Mcewan como director el 04 may 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Simon Jonathan Miller como director el 24 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 29 nov 2020

    19 páginasAA

    legacy

    140 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Nombramiento de Indigo Corporate Secretary Limited como secretario el 14 mar 2022

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Rachel Peat como secretario el 14 mar 2022

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Richard Mark James Crampton como director el 14 ene 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 oct 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Thistledove Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Registro de la carga 034625660007, creada el 26 feb 2021

    80 páginasMR01

    Modification des détails de Thistledove Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 dic 2020

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de , Ground Floor West One London Road, Brentwood, Essex, CM14 4QP, United Kingdom a 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 09 dic 2020

    1 páginasAD01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 24 nov 2019

    18 páginasAA

    legacy

    128 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    ¿Quiénes son los directivos de TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro13253973
    281695990002
    BUTLER, Stuart Clive
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor, Central Square
    West Yorkshire
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor, Central Square
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director127794710001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor, Central Square
    West Yorkshire
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor, Central Square
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Financial Officer187907210001
    MCEWAN, Karen Anita
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor, Central Square
    West Yorkshire
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor, Central Square
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Operating Officer 272054760001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Secretario
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    BritishDirector31500810002
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Secretario
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    PEAT, Rachel
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Secretario
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    256015330001
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Secretario
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237938450001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Director
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector107991420002
    BELL, Robbie Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Director
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishChief Financial Officer97384120002
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Director designado
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CORBY, Caroline Frances
    85 Leverton Street
    NW5 London
    Director
    85 Leverton Street
    NW5 London
    BritishInvestment Banker51774560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Director
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishDirector31500810002
    CRAMPTON, Richard Mark James
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Director
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    United KingdomBritishChief Commercial Officer270535630001
    CURZON, David Joel
    The Forlands 11 Pipers Close
    Rockhill
    B61 7HG Bromsgrove
    Worcestershire
    Director
    The Forlands 11 Pipers Close
    Rockhill
    B61 7HG Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishDirector62340530001
    DUNFOY, Mark Patrick
    11 Heathviews Gardens
    SW15 3SZ London
    Director
    11 Heathviews Gardens
    SW15 3SZ London
    EnglandBritishBanker121433550001
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Director
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector181763320002
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Director
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishDirector209349290001
    KEEN, David John
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector Of Companies56997350002
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Director
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector147052660001
    MILLER, Simon Jonathan
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Director
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector88269280005
    MITCHELL, Philip
    Oak Bank Long Reach
    West Horsley
    KT24 6ND Leatherhead
    Surrey
    Director
    Oak Bank Long Reach
    West Horsley
    KT24 6ND Leatherhead
    Surrey
    BritishDirector Of Companies6907290002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SAUNDERS, David Anthony Roy
    The Spinney
    Toms Lane Linwood
    BH24 3QX Ringwood
    Hampshire
    Director
    The Spinney
    Toms Lane Linwood
    BH24 3QX Ringwood
    Hampshire
    BritishCompany Director74065160001
    SYMONDSON, David Warwick
    1016 Point West
    116 Cromwell Road
    SW7 4XN London
    Director
    1016 Point West
    116 Cromwell Road
    SW7 4XN London
    United KingdomBritishInvestment Director6017570005
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mc Coll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    Director
    Martin Mc Coll House
    Ashwells Road,
    CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishDirector101631100002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TM GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    06 abr 2016
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUk
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03649523
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene TM GROUP HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2021
    Entregado el 08 mar 2021
    Pendiente
    Breve descripción
    All current and future land (except for any restricted land) and intellectual property (except for any restricted ip) owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture"). For more details please refer to the debenture.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited Acting as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 08 mar 2021Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 feb 2020
    Entregado el 05 mar 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    All current and future land (except for any restricted land) and current and future intellectual property (except for any restricted ip) owned by the company, in each case as specified and defined in the debenture registered by this form MR01.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 05 mar 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 13 jul 2016
    Entregado el 20 jul 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Secured Parties (Each as Defined in the Instrument))
    Transacciones
    • 20 jul 2016Registro de una carga (MR01)
    Group debenture
    Creado el 15 mar 2013
    Entregado el 27 mar 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the other mezzanine secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, cash collateral accounts and all monies standing to the credit of the cash collateral accounts, all plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Cavendish Security Trustee Limited (The Mezzanine Security Agent)
    Transacciones
    • 27 mar 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 20 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Group debenture
    Creado el 15 mar 2013
    Entregado el 22 mar 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the other senior secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, cash collateral accounts and all monies standing to the credit of the cash collateral accounts, all plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 22 mar 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 06 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture accession deed
    Creado el 17 oct 2005
    Entregado el 21 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over deposit
    Creado el 24 ago 2001
    Entregado el 28 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The actual contingent present and future obligations and liabilities due or to become due from the company , tm vending limited, fourboys limited and marshell group limited to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) (the "agent")
    Breve descripción
    All interest accrued and accruing thereon and all other rights of the company in relation to such deposit in whichever account such deposit may from time to time be held.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TM GROUP HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 may 2023Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Rachael Wilkinson
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    Profesional
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0