PANTHERIX LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPANTHERIX LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03464985
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PANTHERIX LIMITED?

    • Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PANTHERIX LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o JOHNSTON CARMICHAEL
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PANTHERIX LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AZTECEQUAL LIMITED13 nov 199713 nov 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PANTHERIX LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PANTHERIX LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2016

    7 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Excalibur Fund Managers Ltd Berkeley Square House Berkeley Square Mayfair London W15 6BD a C/O Johnston Carmichael 107-111 Fleet Street London EC4A 2AB el 11 ene 2016

    3 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 22 dic 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 dic 2014

    Estado de capital el 17 dic 2014

    • Capital: GBP 41,822.24
    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    11 páginasAA

    Nombramiento de Farhad Fred Fahid como director

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 jun 2020Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 10/06/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    13 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 nov 2013

    Estado de capital el 26 nov 2013

    • Capital: GBP 41,822.237
    SH01

    Cese del nombramiento de Mark Docherty como director

    2 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cambio de datos del director Mr Mark James Docherty el 07 feb 2013

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2012

    14 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    12 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    11 páginasAA

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2010

    14 páginasAR01

    Nombramiento de Alexander Morrison Mcdougall como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Alexander Morrison Mcdougall como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de John Gonzalez-Carvajal como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PANTHERIX LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Hazelden Road
    Mearnskiry
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    Secretario
    Hazelden Road
    Mearnskiry
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    British156743750001
    FAHID, Farhad
    W8
    Director
    W8
    EnglandBritish186461120001
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    c/o Johnston Carmichael
    Fleet Street
    EC4A 2AB London
    107-111
    Director
    c/o Johnston Carmichael
    Fleet Street
    EC4A 2AB London
    107-111
    United KingdomBritish67155220007
    DOCHERTY, Mark James
    9 The Lye
    Little Gaddesden
    HP4 1UH Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    9 The Lye
    Little Gaddesden
    HP4 1UH Berkhamsted
    Hertfordshire
    British47388290002
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secretario
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    British67155220005
    WHITROW, Jane Elizabeth, Dr
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    Secretario
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British78788220001
    ATLANTIC CORRIE LTD (SC280885)
    Hazelden Road
    Mearnskirk
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    Secretario corporativo
    Hazelden Road
    Mearnskirk
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    107928480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENEDICT, Nicholas Matthew
    Spalentorheg 31
    Basel 4051
    Switzerland
    Director
    Spalentorheg 31
    Basel 4051
    Switzerland
    British131280480001
    CLARK, Alan Stuart
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    Director
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    British67234920002
    COOPER, Robin David Grey
    6740 Dover Road
    FOREIGN Indianapolis
    Indiana 46220
    Usa
    Director
    6740 Dover Road
    FOREIGN Indianapolis
    Indiana 46220
    Usa
    British-Us77211370001
    D'ORSA, Salvatore
    33 King Stret
    SW1Y 6RJ London
    Director
    33 King Stret
    SW1Y 6RJ London
    Italian95545080003
    DOCHERTY, Mark James
    c/o Avlar Bioventures Ltd
    Church Lane
    CB23 8AG Madingley
    Highfield Court
    Cambridgeshire
    England
    Director
    c/o Avlar Bioventures Ltd
    Church Lane
    CB23 8AG Madingley
    Highfield Court
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish47388290006
    FREEMAN, George William
    13 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    Director
    13 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    British70152070002
    GENNERY, Brian Albert, Dr
    6 Qualitas
    RG12 7QG Bracknell
    Berkshire
    Director
    6 Qualitas
    RG12 7QG Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritish89422310001
    GONZALEZ-CARVAJAL, John Ramon, Dr
    Piazzale F Baracca 1
    20123 Milano
    Italy
    Director
    Piazzale F Baracca 1
    20123 Milano
    Italy
    British74227120004
    GREENE, Andrew Fay
    18 Caithness Road
    W14 0JA London
    Director
    18 Caithness Road
    W14 0JA London
    EnglandAmerican86855850001
    HOLT, Elizabeth
    East Garnet House
    Caup Road
    SW19 4UW London
    Director
    East Garnet House
    Caup Road
    SW19 4UW London
    British73547900001
    KEEN, Peter Stephen
    26 Manor Road
    Hemingford Grey
    PE28 9BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    26 Manor Road
    Hemingford Grey
    PE28 9BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish38560002
    LATHAM, Christopher John, Dr
    6 North Gardner Street
    G11 5BT Glasgow
    Director
    6 North Gardner Street
    G11 5BT Glasgow
    British78599550002
    MACDONALD, Cameron Mackay
    10 Paxton Close
    MK46 5PR Olney
    Buckinghamshire
    Director
    10 Paxton Close
    MK46 5PR Olney
    Buckinghamshire
    EnglandBritish56171470001
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    Director
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    British67155220005
    POWELL, Kenneth Leslie, Professor
    Wheatfields Hill Boxes Farm
    Marden Park Woldingham
    CR3 7JD Caterham
    Surrey
    Director
    Wheatfields Hill Boxes Farm
    Marden Park Woldingham
    CR3 7JD Caterham
    Surrey
    British50259160001
    SHAW, William Vare, Professor
    1 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    1 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Lanarkshire
    American57716570002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene PANTHERIX LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture creating a floating charge
    Creado el 01 jul 2004
    Entregado el 19 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever, both present and future including, without limitation, any goodwill and any unpaid share capital of the company;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Merlin Biosciences Fund L.P. Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited,Merlin Biosciences Fund Gbr, Acting by Its Managing Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transacciones
    • 19 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture creating a floating charge
    Creado el 27 feb 2004
    Entregado el 19 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    And any goodwill and any unpaid share capital. Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Merlin Biosciences Fund L.P. and Merlin Biosciences Fund Gbr and Mb Venture Capital Fund 1 Nv
    Transacciones
    • 19 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture creating a floating charge
    Creado el 10 oct 2003
    Entregado el 22 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Merlin Biosciences Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transacciones
    • 22 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Amended and restated convertible secured promissory note
    Creado el 08 oct 2003
    Entregado el 20 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    $2,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All of the company's right, title and interest in and to any and all intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gpc Biotech Ag
    Transacciones
    • 20 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 may 2003
    Entregado el 30 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever, both present and future, including, without limitation, any goodwill and any unpaid share capital of the company.
    Personas con derecho
    • Merlin Biosciences Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited Andmerlin Biosciences Fund Gbr Acting by Its Managing Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transacciones
    • 30 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 abr 2003
    Entregado el 22 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All of the proerty assets and undertaking of the company whatsoever both present and future including without limitation any goodwill and any unpaid share capital of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Merlin Bioscience Fund LP, Merlin Biosciences Fund Gbr & Mb Venture Capital Fund 1 Nv
    Transacciones
    • 22 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Convertible secured promissory note
    Creado el 22 ago 2002
    Entregado el 03 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Us $2,500,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the company's right, title and interest in and to any and all intellectual property rights that are conceived, discovered, identified or first reduced to practice by the company's exercise or certain of the company's rights under the licence agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gpc Biotech Ag
    Transacciones
    • 03 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture creating a floating charge
    Creado el 05 jun 2002
    Entregado el 25 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Merlin Bioscience Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transacciones
    • 25 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 11 ene 2000
    Entregado el 31 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future liabilities of the company to the chargee under pursuant to or in connection with the facility letter dated 11TH january 2000 (together with any letter, deed, documents or other agreement present or future confirming, varying, amending or supplementing such letter) and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Breve descripción
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever both present and future including without limitation any goodwill and any unpaid share capital of the company.
    Personas con derecho
    • Merlin General Partner Limited
    Transacciones
    • 31 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PANTHERIX LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 dic 2015Inicio de la liquidación
    12 abr 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Matthew Purdon Henderson
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    Profesional
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0