CTDI HUNTINGDON LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | CTDI HUNTINGDON LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03467622 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CTDI HUNTINGDON LTD?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra CTDI HUNTINGDON LTD?
| Dirección de la sede social | Ctdi Ltd Featherstone Road Wolverton Mill MK12 5TH Milton Keynes United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CTDI HUNTINGDON LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| REGENERSIS (HUNTINGDON) LTD | 06 jun 2008 | 06 jun 2008 |
| COMMUNICAID LIMITED | 18 nov 1997 | 18 nov 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CTDI HUNTINGDON LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CTDI HUNTINGDON LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 18 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 02 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CTDI HUNTINGDON LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Mr Scott Thomas Taylor como director el 31 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Matthew James Bull como director el 31 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024 | 14 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 16 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Mr Matthew James Bull como director el 23 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Nilesh Chavda como director el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Nombramiento de Mr Thomas Smolne como director el 31 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cambio de datos del secretario Clc Secretarial Services Ltd el 01 dic 2022 | 1 páginas | CH04 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 16 páginas | AA | ||||||
Segunda presentación para el nombramiento de Mr Nilesh Chavda como director | 3 páginas | RP04AP01 | ||||||
Nombramiento de Mr Nilesh Chavda como director el 27 jul 2023 | 3 páginas | AP01 | ||||||
| ||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Bull como director el 27 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Thomas Smolne como director el 27 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021 | 16 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020 | 16 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019 | 16 páginas | AA | ||||||
Cese del nombramiento de Leo David Parsons como director el 17 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Gerald Joseph Parsons como director el 17 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||||||
¿Quiénes son los directivos de CTDI HUNTINGDON LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLC SECRETARIAL SERVICES LTD | Secretario corporativo | 20 King Street EC2V 8EG London 3rd Floor England |
| 249037320001 | ||||||||||
| SMOLNE, Thomas | Director | Featherstone Road Wolverton Mill MK12 5TH Milton Keynes Ctdi Ltd United Kingdom | Germany | German | 318962010001 | |||||||||
| TAYLOR, Scott Thomas | Director | Featherstone Road Wolverton Mill MK12 5TH Milton Keynes Ctdi Ltd United Kingdom | Scotland | British | 245626770001 | |||||||||
| BOWEN, John | Secretario | Flowergate 5 Heol Don Whitchurch CF14 2AR Cardiff | British | 33947050001 | ||||||||||
| CROCKER, Arthur Rupert | Secretario | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | British | 79797070001 | ||||||||||
| MATTHEWS, Christopher John | Secretario | The Long House Hillesden Road, Gawcott MK18 4JF Buckingham Buckinghamshire | British | 59807870002 | ||||||||||
| TEMPLE, John Nicholas | Secretario | Windfalls Highfield Road West Moors BH22 0NA Ferndown Dorset | British | 84493950001 | ||||||||||
| WEATHERALL, Sally | Secretario | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | 152389750001 | |||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London Shakespeare Martineau Llp United Kingdom |
| 165261700001 | ||||||||||
| PRISM COSEC LIMITED | Secretario corporativo | 10 Margaret Street W1W 8RL London Prism Cosec United Kingdom |
| 116519070002 | ||||||||||
| RUGBY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 3 Whitehall Road CV21 3AE Rugby Warwickshire | 2497100001 | |||||||||||
| BAKER, John Frederick, Dr | Director | 22 Cherry Hill Road Barnt Green B45 8LJ Birmingham West Midlands | England | British | 110330180001 | |||||||||
| BIRD, Anthony Malcolm David | Director | Failand Hill House Horse Race Lane Lower Failand BS8 3TY Bristol Avon | England | British | 38086950001 | |||||||||
| BOWEN, John | Director | Flowergate 5 Heol Don Whitchurch CF14 2AR Cardiff | United Kingdom | British | 33947050001 | |||||||||
| BULL, Matthew James | Director | Featherstone Road Wolverton Mill MK12 5TH Milton Keynes Ctdi Ltd United Kingdom | England | British | 241150430001 | |||||||||
| BULL, Matthew | Director | Featherstone Road Wolverton Mill MK12 5TH Milton Keynes Ctdi Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | 241551800001 | |||||||||
| CHAVDA, Nilesh Virji | Director | Featherstone Road Wolverton Mill MK12 5TH Milton Keynes Ctdi Ltd United Kingdom | England | British | 312121030001 | |||||||||
| CONAFRAY, Patrick John | Director | The Old Rickyard Sydenham Road OX39 4LR Sydenham Oxfordshire | British | 111512810001 | ||||||||||
| CROCKER, Arthur Rupert | Director | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | England | British | 79797070001 | |||||||||
| CURRILL, Colin George | Director | 17 Bickerton Road Headington OX3 7LT Oxford Oxfordshire | British | 1832150001 | ||||||||||
| CURRILL, George Frederick | Director | 51 Kennett Road Headington OX3 7BH Oxford Oxfordshire | British | 1832160001 | ||||||||||
| DHODY, Jog | Director | High Street TN9 1BE Tonbridge 190 Kent United Kingdom | England | British | 104269910005 | |||||||||
| HARPER, Simon Julian | Director | High Street TN9 1BE Tonbridge 190 Kent United Kingdom | England | British | 108485480003 | |||||||||
| HELLEWELL, Wayne Patrick | Director | High Street TN9 1BE Tonbridge 190 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 185877540001 | |||||||||
| HOLLAND, Christine Elizabeth | Director | 3 Ashleigh Close Barby CV23 8UG Rugby Warwickshire | British | 12566520001 | ||||||||||
| HOLLAND, Colin | Director | Watford Court Spinney Church Street Watford NN6 7UR Northampton | British | 12566530002 | ||||||||||
| HOLLAND, Colin | Director | 3 Ashleigh Close Barby CV23 8UG Rugby Warwickshire | British | 12566530001 | ||||||||||
| HOWE, Christopher | Director | Featherstone Road Wolverton Mill MK12 5TH Milton Keynes Ctdi Ltd United Kingdom | United States | American | 207227000001 | |||||||||
| KELHAM, David William | Director | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | United Kingdom | British | 152816550001 | |||||||||
| KELHAM, David William | Director | 4 Elm Place Old Witney Road, Eynsham, Witney OX29 4BD Oxfordshire | England | British | 87146390001 | |||||||||
| KING, Paul William | Director | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 199010760001 | |||||||||
| LEE, Andrew Stephen | Director | Floor 32 Wigmore Street W1U 2RP London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | 159105430001 | |||||||||
| MATTHEWS, Christopher John | Director | The Long House Hillesden Road, Gawcott MK18 4JF Buckingham Buckinghamshire | England | British | 59807870002 | |||||||||
| MCLAUGHLIN, Alan | Director | 4 Woodstock Close OX2 8DB Oxford Oxfordshire | British | 91543760001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CTDI HUNTINGDON LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctdi (Depot) Services Ltd | 06 abr 2016 | MK12 5TH Wolverton Mill Featherstone Road Milton Keynes United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0