PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED

PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03470856
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Jubilee House
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ELBA INVESTMENTS PLC15 dic 199715 dic 1997
    WELLINGTON FINANCE PLC19 nov 199719 nov 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el11 ago 2022
    Próximas cuentas vencen el11 may 2023
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta15 ago 2021

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta29 nov 2023
    Próxima declaración de confirmación vence13 dic 2023
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta29 nov 2022
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2025

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2024

    8 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 mar 2023

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 mar 2023

    • Capital: GBP 9,367,887
    3 páginasSH01

    Estado de capital el 09 mar 2023

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled/reserve account credited to profit and loss account 09/03/2023
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Removal of directors and appointment of director 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    8 páginasMA

    Nombramiento de Mr Derek Anthony Howell como director el 01 feb 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 22 ago 2022

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 15 ago 2021

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 16 ago 2020

    4 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 24 ago 2020 au 11 ago 2020

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2019

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2018

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Director
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritish299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191629720001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175490400001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Secretario
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161809430001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish55975990001
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Director
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Director
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MYERS, Roger
    Fern Lodge
    5 Millfield Lane Highgate
    N6 6JL London
    Director
    Fern Lodge
    5 Millfield Lane Highgate
    N6 6JL London
    United KingdomBritish56413030004
    OSMOND, Hugh
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    Director
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    British6209210002
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Director
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001
    SHURE, Randl Louis
    45 Addison Road
    W14 8JH London
    Director
    45 Addison Road
    W14 8JH London
    Usa57895060001
    THORLEY, Giles Alexander
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81928120002
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish128819260001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3512367
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second ranking fixed and floating security document
    Creado el 08 dic 2006
    Entregado el 18 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transacciones
    • 18 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 16 ene 2006
    Entregado el 23 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First legal mortgage all property in england and wales,first fixed euitable charge all other property,first fixed charge all its present and future book debts,bank accounts,investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 23 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge and priority
    Creado el 01 sept 1999
    Entregado el 21 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee of punch group limited's obligations under a deed poll constituting series a loan notes due 2009 to a maximum of £146,000,000
    Breve descripción
    All real property,plant,machinery and equipment owned by the chargor and all investments,rights,goodwill of business and all uncalled capital; all book debts and bank balances and all other assets,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 21 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 mar 2023Inicio de la liquidación
    21 mar 2023Fecha de la declaración de solvencia jurada
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0