TARGET EXPRESS LIMITED

TARGET EXPRESS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTARGET EXPRESS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03472732
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TARGET EXPRESS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TARGET EXPRESS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Compass House
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    West Sussex
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TARGET EXPRESS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BROOMCO (1437) LIMITED28 nov 199728 nov 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TARGET EXPRESS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TARGET EXPRESS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta28 mar 2025
    Próxima declaración de confirmación vence11 abr 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta28 mar 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TARGET EXPRESS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cambio de datos del director Ms Bente Salt el 31 ago 2024

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Christopher Brian Terrence Filby como director el 31 ago 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Bente Salt como director el 31 ago 2024

    2 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 sept 2024Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 24.09.2024 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Nombramiento de Mr Michael Ellis como director el 31 ago 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jeffreys Kristen Hampson como director el 31 ago 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr James Robert Anthony Gordon como secretario el 01 abr 2024

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr James Robert Anthony Gordon como director el 01 abr 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Catherine Stead como secretario el 31 mar 2024

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Catherine Jane Stead como director el 31 mar 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Daragh Patrick Feltrim Fagan como director el 30 mar 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Catherine Jane Stead como director el 01 abr 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    4 páginasAA

    Modification des détails de Target Express Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2021

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Riverbank Meadows Business Park Blackwater Camberley Surrey GU17 9AB a Compass House Manor Royal Crawley West Sussex RH10 9PY el 01 abr 2021

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 08 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Daragh Patrick Feltrim Fagan el 17 dic 2020

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Catherine Stead el 17 dic 2020

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Jeffreys Kristen Hampson el 17 dic 2020

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de TARGET EXPRESS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GORDON, James Robert Anthony
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Secretario
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    321552270001
    ELLIS, Michael
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant326346850001
    GORDON, James Robert Anthony
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary321552190001
    SALT, Bente
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201902470001
    BROWN, Gareth Trevor
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    Secretario
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2
    West Sussex
    England
    British15885460002
    COTTERILL, Mark Bernard
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    British9541300002
    FAGAN, Daragh Patrick Feltrim
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Secretario
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    207698020001
    JOHNSON, Kenneth
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    Secretario
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    BritishCompany Secretary56853980002
    LAAN, Alexandra Jane
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Secretario
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    British89963780002
    STEAD, Catherine
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Secretario
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    211845440001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BROOM, Keith
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    Director
    Target Express House
    Woodlands Park Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Merseyside
    BritishFinance Director42112330008
    COOKE, Michael Andrew
    Somerley Middle Drive
    TN22 2HG Maresfield Park
    East Sussex
    Director
    Somerley Middle Drive
    TN22 2HG Maresfield Park
    East Sussex
    BritishCompany Director58733830001
    COTTERILL, Mark Bernard
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    Director
    20 Buxton Old Road
    SK11 7EL Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant9541300002
    CVETKOVIC, Petar
    Target Express House
    Woodlands Park, Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    Director
    Target Express House
    Woodlands Park, Ashton Road
    WA12 0HF Newton Le Willows
    BritishDirector59602020005
    CVETKOVIK, Petar
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Highlands
    Cheshire
    Director
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Highlands
    Cheshire
    BritishCompany Director129068030001
    FAGAN, Daragh Patrick Feltrim
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor189709530001
    FILBY, Christopher Brian Terrence
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director110498520001
    GODMAN, Stuart
    Appletree Road
    OX17 1LW Chipping Warden
    18
    Oxfordshire
    Director
    Appletree Road
    OX17 1LW Chipping Warden
    18
    Oxfordshire
    UkBritishManaging Director132540700001
    GRIFFITHS, Paul
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2 City Place
    West Sussex
    England
    Director
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2 City Place
    West Sussex
    England
    EnglandBritishChartered Secretary11329830003
    GRIFFITHS, Paul
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0HA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    Director
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0HA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    EnglandBritishChartered Secretary11329830003
    GRIFFITHS, Raymond Gordon
    248 Burnley Road
    Weir
    OL13 8QR Bacup
    Lancashire
    Director
    248 Burnley Road
    Weir
    OL13 8QR Bacup
    Lancashire
    BritishCompany Director5115700001
    HAMPSON, Jeffreys Kristen
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    Director
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director178768280001
    HARRISON, Michael Glyn
    Flat 1
    70 Tottenham Road
    N1 4ER London
    Director
    Flat 1
    70 Tottenham Road
    N1 4ER London
    BritishExecutive110257110001
    HAUCK, Jonathan Ellis
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Director
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    United KingdomBritishAccountant129931020001
    HAUGHEY, Patricia Mary
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    Director
    Meadows Business Park
    Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverbank
    Surrey
    England
    United KingdomBritishCompany Director208079560001
    HENDERSON, Adele
    Siskin Parkway West
    Baginton
    CV3 4PA Coventry
    Coventry Airpark
    West Midlands
    England
    Director
    Siskin Parkway West
    Baginton
    CV3 4PA Coventry
    Coventry Airpark
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishCompany Director170676450001
    HEYWOOD, Ivan Maxwell
    The Old Parsonage
    The Street Long Sutton
    RG29 1SS Hook
    Hampshire
    Director
    The Old Parsonage
    The Street Long Sutton
    RG29 1SS Hook
    Hampshire
    BritishVenture Capitalist57119520002
    INGALL-TOMBS, Stuart Michael
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2 City Place
    West Sussex
    England
    Director
    Beehive Ring Road
    RH6 0HA Gatwick Airport
    2 City Place
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishAccountant273129080001
    JENKINS, Brian
    1 Netherfield Court
    Roch Valley Way
    OL11 4BZ Rochdale
    Lancashire
    Director
    1 Netherfield Court
    Roch Valley Way
    OL11 4BZ Rochdale
    Lancashire
    BritishSales Director56957130003
    JOHNSON, Adrian Robert Barnett
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    Director
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    BritishVenture Capitalist57119570001
    JOHNSON, Kenneth
    29 Patch Croft Road Peel Hall
    Wythenshawe
    M22 5JR Manchester
    Director
    29 Patch Croft Road Peel Hall
    Wythenshawe
    M22 5JR Manchester
    United KingdomBritishAccountant56853980003
    KENYON, Martin
    44 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    Director
    44 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    EnglandUnited KingdomOperations Director58648840001
    MURRAY, Paul
    High Point
    Tirley Lane Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Director
    High Point
    Tirley Lane Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    BritishManaging Director56957060002
    PETO, Robert James
    Siskin Parkway West
    Baginton
    CV3 4PA Coventry
    Coventry Airpark
    England
    Director
    Siskin Parkway West
    Baginton
    CV3 4PA Coventry
    Coventry Airpark
    England
    United KingdomBritishFinance Director196399770001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TARGET EXPRESS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Manor Royal
    RH10 9PY Crawley
    Compass House
    West Sussex
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03917510
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TARGET EXPRESS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 05 sept 2006
    Entregado el 15 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The l/h premises k/a land at merrivale road okehampton devon (also k/a land at exeter road industrial estate okehampton devon) t/n DN412848. The l/h premises k/a barley castle trading estate barley castle lane appleton warrington cheshire t/n CH340963 (also k/a land lying to the south-east of lyncastle road appleton) the l/h premises k/a 22 eastbury road the london industrial park beckton london t/n EGL300427. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch
    Transacciones
    • 15 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 26 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture between target express holdings limited, target express limited, target express parcels limited, target international logistics limited and mizuho corporate bank LTD., As security agent for itself and each of the secured parties
    Creado el 11 oct 2002
    Entregado el 25 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mizuho Corporate Bank LTD., as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 25 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between target express holdings limited, target express limited, target express parcels limited, target international logistics limited (and each company which becomes a party to the debenture by executing a deed of accession) and the fuji bank,limited as agent and trustee for itself and each of the lenders
    Creado el 18 feb 2000
    Entregado el 03 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as both defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Fuji Bank,Limited
    Transacciones
    • 03 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Creado el 03 feb 1998
    Entregado el 06 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge and/or the cash collateral deed
    Breve descripción
    First fixed charge all it's right title and interest in and to tthe deposit moneys and the debts represented by the deposit moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 07 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between target international logistics limited, target express parcels limited and broomco (1437) limited (together the chargors) and the fuji bank limited as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (the security agent)
    Creado el 02 feb 1998
    Entregado el 11 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) and the mezzanine finance documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Fuji Bank Limited
    Transacciones
    • 11 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0