RAL REALISATIONS 2011 LIMITED

RAL REALISATIONS 2011 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAL REALISATIONS 2011 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03474127
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    • (3614) /
    • (3615) /

    ¿Dónde se encuentra RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    REST ASSURED LIMITED29 ene 199829 ene 1998
    PINCO 996 LIMITED01 dic 199701 dic 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 ene 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 28 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ago 2011

    Estado de capital el 28 ago 2011

    • Capital: GBP 700,000
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 26 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Paul Mckoen como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Paul Mckoen como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Paul Mckoen como director

    2 páginasTM01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed rest assured LIMITED\certificate issued on 15/06/11
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 08 jun 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    legacy

    12 páginasMG01

    Déclaration annuelle établie au 26 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 ene 2010

    17 páginasAA

    Cambio de datos del director Neal Gerard Mernock el 06 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Seth Mckoen el 06 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Paul Seth Mckoen el 06 oct 2009

    1 páginasCH03

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2009

    21 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 feb 2008

    22 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    ¿Quiénes son los directivos de RAL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MERNOCK, Neal Gerard
    100
    BB18 6WT Barnoldswick
    Long Ing Lane
    Lancashire
    Director
    100
    BB18 6WT Barnoldswick
    Long Ing Lane
    Lancashire
    United KingdomBritish67905570005
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    British106771550001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    COLEY, James Robert Ewen
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    Secretario
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    British68949300004
    HOPE, Richard Geoffrey
    12 Kingsway
    Great Harwood
    BB6 7XA Blackburn
    Lancashire
    Secretario
    12 Kingsway
    Great Harwood
    BB6 7XA Blackburn
    Lancashire
    British32541300001
    JONES, Robert Glyn
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    Secretario
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    British116871110002
    MCKOEN, Paul Seth
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    Secretario
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    British49935600005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Secretario
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Secretario designado corporativo
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish106771550001
    ALLENZA, Antonino
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    Director
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    British39237330004
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    CLARK, Andrew William
    5 Ryedale Park
    LS29 8SG Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    5 Ryedale Park
    LS29 8SG Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomEnglish102836380001
    COLEY, James Robert Ewen
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    Director
    Herongate
    39 Meadow Drive
    SK10 4EY Prestbury
    Cheshire
    United KingdomBritish68949300004
    GILL, Stephen Paul
    28 Browgate
    Sawley
    BB7 4NB Clitheroe
    Lancashire
    Director
    28 Browgate
    Sawley
    BB7 4NB Clitheroe
    Lancashire
    British59486300001
    IDDON, Joanne
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    Director
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish92755390001
    MCILROY, Michael
    Mayfield Bent Cottages
    301 Keighley Road
    BB8 7HE Colne
    Lancashire
    Director
    Mayfield Bent Cottages
    301 Keighley Road
    BB8 7HE Colne
    Lancashire
    British63014400001
    MCKENZIE, Barry
    Mingulay
    Farleton
    LA2 9LF Lancaster
    Director
    Mingulay
    Farleton
    LA2 9LF Lancaster
    British1164360001
    MCKOEN, Paul Seth
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    Director
    P O Box 100 Long Ing Lane
    Barnoldswick
    BB18 6WT Lancashire
    EnglandBritish49935600005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Director
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottish146642810001
    SCOTT, Michelle
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    Director
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    British51740980003
    SIMPSON, William
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    Director
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish14163900002
    TOWERS, Martin George
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    Director
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    British36252860002
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Director designado corporativo
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001

    ¿Tiene RAL REALISATIONS 2011 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 12 feb 2011
    Entregado el 18 feb 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the cahrgors to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Grace Bay Ii Holdings Sarl
    Transacciones
    • 18 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 29 ene 2004
    Entregado el 07 feb 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 07 feb 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 22 oct 2003
    Entregado el 28 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 28 oct 2003Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0