LIFE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLIFE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03474139
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LIFE LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra LIFE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LIFE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PINCO 999 LIMITED01 dic 199701 dic 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LIFE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 feb 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIFE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Philip Hedley Bowcock como director el 14 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Terence Douglas como director el 14 nov 2011

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 ago 2011

    Estado de capital el 16 ago 2011

    • Capital: GBP 3,330,224
    SH01

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Philip Hedley Bowcock como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Jayne Fearn como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como secretario

    1 páginasTM02

    legacy

    23 páginasMG01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 feb 2010

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Andrew Marks como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Luminar Leisure Limited como director

    2 páginasAP02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2009

    8 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    8 páginas395

    legacy

    8 páginas395

    legacy

    9 páginas395

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2008

    10 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    3 páginas403a

    legacy

    7 páginas363s

    ¿Quiénes son los directivos de LIFE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Secretario
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158741750001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Director corporativo
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro03802937
    152128400001
    FRIEND, Lynne
    Windborne House
    Ashbourne Road Turnditch
    DE56 2LH Derby
    Derbyshire
    Secretario
    Windborne House
    Ashbourne Road Turnditch
    DE56 2LH Derby
    Derbyshire
    British59349000001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    PORTER, Hugh Leslie
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    Secretario
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    British63443690001
    ROBERTS, Jeremy Kevin
    29 River Street
    SK9 4AB Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    29 River Street
    SK9 4AB Wilmslow
    Cheshire
    British44233980001
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    THORPE, Elizabeth Anne
    85 Silverdale Road
    Earley
    RG6 7NF Reading
    Berkshire
    Secretario
    85 Silverdale Road
    Earley
    RG6 7NF Reading
    Berkshire
    British63473530001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Secretario designado corporativo
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ANDREW, Derek
    Church Hill House
    Church Hill, Kinver
    DY7 6HY Stourbridge
    West Midlands
    Director
    Church Hill House
    Church Hill, Kinver
    DY7 6HY Stourbridge
    West Midlands
    British66854930001
    BACON, Timothy Alan
    Chantry Cottage
    Brookhouse Green
    CW11 2XF Smallwood
    Cheshire
    Director
    Chantry Cottage
    Brookhouse Green
    CW11 2XF Smallwood
    Cheshire
    EnglandBritish66652780001
    BARRATT, Simon Charles
    Longwood
    Langton Green
    TN3 0BA Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Longwood
    Langton Green
    TN3 0BA Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish14044440005
    BONNELL, William Andrew
    Ferry Lane Barn
    Ferry Road
    RG8 0JL South Stoke
    Director
    Ferry Lane Barn
    Ferry Road
    RG8 0JL South Stoke
    British101547740001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Director
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Director
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BUCHAN, William James
    Winkworth Grange
    Hascombe Road South Munstead
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    Director
    Winkworth Grange
    Hascombe Road South Munstead
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    EnglandBritish79917240001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Director
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Director
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    FENNEY, Paul Francis
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    Director
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish97980790001
    HINDS, John David
    The Granary
    Lower Wallington
    LL13 0AN Worthenbury
    Wrexham
    Director
    The Granary
    Lower Wallington
    LL13 0AN Worthenbury
    Wrexham
    United KingdomBritish83825290003
    JONES, Mark Vincent
    5 Lake View
    Moor Hall Lane St Michaels Head
    CM23 4GZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    5 Lake View
    Moor Hall Lane St Michaels Head
    CM23 4GZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British81765510001
    LIVINGSTONE, David Barry Hindle
    Lakeside 20 Lakeside Road
    WA13 0QE Lymm
    Cheshire
    Director
    Lakeside 20 Lakeside Road
    WA13 0QE Lymm
    Cheshire
    British142596910001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Director
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    ROBERTS, Jeremy Kevin
    Wyndcroft
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Wyndcroft
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish44233980002
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Director
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    TAYLOR, Andrew Herbert Ian
    10 Aldwycks Close
    MK5 6HZ Milton Keynes
    Director
    10 Aldwycks Close
    MK5 6HZ Milton Keynes
    United KingdomBritish116794160001
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Director
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Director
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Director designado corporativo
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001

    ¿Tiene LIFE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 dic 2010
    Entregado el 15 dic 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of mortgage property please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtrues, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 15 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    Deed dated 20 february 2009 creating a floating charge
    Creado el 20 feb 2009
    Entregado el 27 feb 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge its undertaking and all its assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 2009Registro de un cargo (395)
    Deed
    Creado el 20 feb 2009
    Entregado el 27 feb 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 2009Registro de un cargo (395)
    Deed creating a floating charge
    Creado el 20 feb 2009
    Entregado el 27 feb 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of floating charge its undertaking and all its assets both present and future see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 2009Registro de un cargo (395)
    Floating charge
    Creado el 15 ago 2007
    Entregado el 30 ago 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditors
    Transacciones
    • 30 ago 2007Registro de un cargo (395)
    Floating charge
    Creado el 16 dic 2004
    Entregado el 22 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transacciones
    • 22 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 23 jul 2004
    Entregado el 04 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge its undertaking and all assets present and future.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transacciones
    • 04 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 ene 1999
    Entregado el 25 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Breve descripción
    L/H licensed premises k/a 1A bold street liverpool and any proceeds of sale and all buildings and fixtures (including trade fixtures), the insurance policy taken out in respect of the property, the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transacciones
    • 25 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 13 ene 1999
    Entregado el 19 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities now or hereafer due, owing or incurred by the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage: outside front - 10, stainless steel effect pedestal pavement cafe tables on pedestal supports with splayed feet. 34, stainless steel effect open arm pavement chairs with black woven seats and backs. Raised patio section - 4, ditto stainless steel pedestal tables.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transacciones
    • 19 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 feb 1998
    Entregado el 10 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transacciones
    • 10 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0