TECHNICA UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTECHNICA UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03475331
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TECHNICA UK LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TECHNICA UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    37 Carr Lane
    Hull
    HU1 3RE East Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TECHNICA UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TECHNICA UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 03 dic 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Paul Simon Simpson como director el 11 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    13 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 23 mar 2016

    • Capital: GBP 0.0065
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account and capital redemption reserve 22/03/2016
    RES13

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 dic 2015

    Estado de capital el 04 dic 2015

    • Capital: GBP 650
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 dic 2014

    Estado de capital el 03 dic 2014

    • Capital: GBP 650
    SH01

    Cambio de datos del director Mr William George Halbert el 18 ago 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 dic 2013

    Estado de capital el 04 dic 2013

    • Capital: GBP 650
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr William George Halbert el 24 ago 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de TECHNICA UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMITH, Katharine Olivia Helen
    Brandy Carr Road
    Wrenthorpe
    WF2 0UG Wakefield
    Melbourne House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Brandy Carr Road
    Wrenthorpe
    WF2 0UG Wakefield
    Melbourne House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    153647210001
    HALBERT, William George
    c/o 2nd Floor
    Finsbury Square
    EC2A 1DS London
    26
    England
    Director
    c/o 2nd Floor
    Finsbury Square
    EC2A 1DS London
    26
    England
    EnglandBritish13311440002
    BAILEY, John Philip Cureton
    7 Thornleys
    Bishop Burton Road
    HU17 7SJ Cherry Burton
    East Yorkshire
    Secretario
    7 Thornleys
    Bishop Burton Road
    HU17 7SJ Cherry Burton
    East Yorkshire
    British1441700001
    FOGARTY, Patrick
    Bruckey
    Castlegar
    County Galway
    Ireland
    Secretario
    Bruckey
    Castlegar
    County Galway
    Ireland
    Irish55974940002
    KAPOOR, Rakesh
    97 Park Hall Road
    WV4 5EJ Wolverhampton
    Secretario
    97 Park Hall Road
    WV4 5EJ Wolverhampton
    British35848690001
    MCDONALD, Elizabeth Mary
    Moorside
    Slaithwaite
    HD7 5UU Huddersfield
    4
    West Yorkshire
    Secretario
    Moorside
    Slaithwaite
    HD7 5UU Huddersfield
    4
    West Yorkshire
    Other137662250001
    MILLER, Nicola Jane
    Brandy Carr Road
    Wrenthorpe
    WF2 0UG Wakefield
    Melbourne House
    West Yorkshire
    England
    Secretario
    Brandy Carr Road
    Wrenthorpe
    WF2 0UG Wakefield
    Melbourne House
    West Yorkshire
    England
    147169990001
    ROBINSON, Denise Brenda
    135 Belgrave Drive
    HU4 6DP Hull
    East Yorkshire
    Secretario
    135 Belgrave Drive
    HU4 6DP Hull
    East Yorkshire
    British112343690001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    COLLINS, Liam Patrick John
    25 Bartley Woods
    B32 3RB Birmingham
    Director
    25 Bartley Woods
    B32 3RB Birmingham
    EnglandBritish56517800002
    FALLEN, Malcolm James
    Madleigh House
    Village Road
    HP7 0LQ Coleshill
    Buckinghamshire
    Director
    Madleigh House
    Village Road
    HP7 0LQ Coleshill
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish74254840008
    FOGARTY, Patrick
    Bruckey
    Castlegar
    County Galway
    Ireland
    Director
    Bruckey
    Castlegar
    County Galway
    Ireland
    Irish55974940002
    GIBSON, John Andrew
    Manor Farm
    Spoonley
    TF9 3SR Market Drayton
    Shropshire
    Director
    Manor Farm
    Spoonley
    TF9 3SR Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritish58033070002
    KAPOOR, Rakesh
    97 Park Hall Road
    WV4 5EJ Wolverhampton
    Director
    97 Park Hall Road
    WV4 5EJ Wolverhampton
    United KingdomBritish35848690001
    PEREZ, Steven
    19 Malham Close
    CV11 6WW Nuneaton
    Warwickshire
    Director
    19 Malham Close
    CV11 6WW Nuneaton
    Warwickshire
    American69941550002
    SIMPSON, Paul Simon
    Brandy Carr Road
    Wrenthorpe
    WF2 0UG Wakefield
    Melbourne House
    West Yorkshire
    England
    Director
    Brandy Carr Road
    Wrenthorpe
    WF2 0UG Wakefield
    Melbourne House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish98311220002
    SMITH, Andrew John
    Vine Cottage
    The Street, Alveston
    BS35 3SX Bristol
    Director
    Vine Cottage
    The Street, Alveston
    BS35 3SX Bristol
    UkBritish62157060005
    STOKES, Graham Neil
    66 Granville Gardens
    LE10 0JD Hinckley
    Leicestershire
    Director
    66 Granville Gardens
    LE10 0JD Hinckley
    Leicestershire
    British58033200001
    THOMPSON, Derek Paul
    2 Sandbarn Close
    Monkspath
    B90 4TQ Solihull
    West Midlands
    Director
    2 Sandbarn Close
    Monkspath
    B90 4TQ Solihull
    West Midlands
    British50719350003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TECHNICA UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Carr Lane
    HU1 3RE Hull
    37
    England
    03 dic 2016
    Carr Lane
    HU1 3RE Hull
    37
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro6072997
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de un fideicomiso, y los fiduciarios de ese fideicomiso (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Carr Lane
    HU1 3RE Hull
    37
    England
    03 dic 2016
    Carr Lane
    HU1 3RE Hull
    37
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2150618
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene TECHNICA UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 10 ene 2002
    Entregado el 15 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The balance from time to time in the account initially comprising the initial deposit of £44,716.10.
    Personas con derecho
    • Hicks Developments Limited
    Transacciones
    • 15 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 oct 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 17 ago 2000
    Entregado el 30 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 jun 1999
    Entregado el 16 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0