TECHNICA UK LIMITED
Visi ón general
| Nombre de la empresa | TECHNICA UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03475331 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TECHNICA UK LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra TECHNICA UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 37 Carr Lane Hull HU1 3RE East Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TECHNICA UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TECHNICA UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 dic 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Simon Simpson como director el 11 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 13 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 23 mar 2016
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr William George Halbert el 18 ago 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr William George Halbert el 24 ago 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TECHNICA UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Katharine Olivia Helen | Secretario | Brandy Carr Road Wrenthorpe WF2 0UG Wakefield Melbourne House West Yorkshire United Kingdom | 153647210001 | |||||||
| HALBERT, William George | Director | c/o 2nd Floor Finsbury Square EC2A 1DS London 26 England | England | British | 13311440002 | |||||
| BAILEY, John Philip Cureton | Secretario | 7 Thornleys Bishop Burton Road HU17 7SJ Cherry Burton East Yorkshire | British | 1441700001 | ||||||
| FOGARTY, Patrick | Secretario | Bruckey Castlegar County Galway Ireland | Irish | 55974940002 | ||||||
| KAPOOR, Rakesh | Secretario | 97 Park Hall Road WV4 5EJ Wolverhampton | British | 35848690001 | ||||||
| MCDONALD, Elizabeth Mary | Secretario | Moorside Slaithwaite HD7 5UU Huddersfield 4 West Yorkshire | Other | 137662250001 | ||||||
| MILLER, Nicola Jane | Secretario | Brandy Carr Road Wrenthorpe WF2 0UG Wakefield Melbourne House West Yorkshire England | 147169990001 | |||||||
| ROBINSON, Denise Brenda | Secretario | 135 Belgrave Drive HU4 6DP Hull East Yorkshire | British | 112343690001 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| COLLINS, Liam Patrick John | Director | 25 Bartley Woods B32 3RB Birmingham | England | British | 56517800002 | |||||
| FALLEN, Malcolm James | Director | Madleigh House Village Road HP7 0LQ Coleshill Buckinghamshire | England | English | 74254840008 | |||||
| FOGARTY, Patrick | Director | Bruckey Castlegar County Galway Ireland | Irish | 55974940002 | ||||||
| GIBSON, John Andrew | Director | Manor Farm Spoonley TF9 3SR Market Drayton Shropshire | England | British | 58033070002 | |||||
| KAPOOR, Rakesh | Director | 97 Park Hall Road WV4 5EJ Wolverhampton | United Kingdom | British | 35848690001 | |||||
| PEREZ, Steven | Director | 19 Malham Close CV11 6WW Nuneaton Warwickshire | American | 69941550002 | ||||||
| SIMPSON, Paul Simon | Director | Brandy Carr Road Wrenthorpe WF2 0UG Wakefield Melbourne House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 98311220002 | |||||
| SMITH, Andrew John | Director | Vine Cottage The Street, Alveston BS35 3SX Bristol | Uk | British | 62157060005 | |||||
| STOKES, Graham Neil | Director | 66 Granville Gardens LE10 0JD Hinckley Leicestershire | British | 58033200001 | ||||||
| THOMPSON, Derek Paul | Director | 2 Sandbarn Close Monkspath B90 4TQ Solihull West Midlands | British | 50719350003 | ||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TECHNICA UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kch (Holdings) Limited | 03 dic 2016 | Carr Lane HU1 3RE Hull 37 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Kcom Group Plc | 03 dic 2016 | Carr Lane HU1 3RE Hull 37 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TECHNICA UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creado el 10 ene 2002 Entregado el 15 ene 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The balance from time to time in the account initially comprising the initial deposit of £44,716.10. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 17 ago 2000 Entregado el 30 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 jun 1999 Entregado el 16 jun 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0