MOON 2000 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMOON 2000 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03479238
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MOON 2000 LIMITED?

    • (7487) /

    ¿Dónde se encuentra MOON 2000 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    99 Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    Uk
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MOON 2000 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MOON 2000 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 02 jun 2010

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de disminución del capital social autorizado

    RES05

    Estado de capital el 18 may 2010

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 11 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ola Tricia Aramita Barreto-Morley el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Philip Matthew Deakin el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario S & J Registrars Limited el 01 oct 2009

    2 páginasCH04

    Cambio de datos del director Giles Hudson el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Edward Ufland el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Philip Matthew Deakin como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gavin Udall como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Philip Matthew Deakin como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Philip Matthew Deakin como director

    2 páginasAP01

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de MOON 2000 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Floor 99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    5th
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor 99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    5th
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01740543
    132600000001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Director
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Director
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Director
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritish161583790001
    UFLAND, Edward
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Director
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritish133319140001
    BURNHOPE, Mark Edward
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    Secretario
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    English60709550001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Secretario designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    REX, Simon John
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    Secretario
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    British11273460001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    8 Dawnay Close
    SL5 7PQ Ascot
    Woodhaven
    Berkshire
    Director
    8 Dawnay Close
    SL5 7PQ Ascot
    Woodhaven
    Berkshire
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    BURNHOPE, Mark Edward
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    Director
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    EnglandEnglish60709550001
    COLE, Peter Gregory
    Wightwick Mill Barn
    203 Bridgnorth Road
    WV6 8BD Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Wightwick Mill Barn
    203 Bridgnorth Road
    WV6 8BD Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish112413650001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Wellington Court
    Spencers Wood
    RG7 1BN Reading
    12
    Berkshire
    Director
    Wellington Court
    Spencers Wood
    RG7 1BN Reading
    12
    Berkshire
    United KingdomBritish146225080002
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Director designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    MCKAY, Michael William Hoy
    Peggs Farm
    Orton On The Hill
    CV9 3NE Atherstone
    Warwickshire
    Director
    Peggs Farm
    Orton On The Hill
    CV9 3NE Atherstone
    Warwickshire
    United KingdomBritish53050860001
    REX, Simon John
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British11273460001
    REX, Simon John
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British11273460001
    SKEGGS, Douglas Frederick
    Tre Ribble Barn
    HR2 8LS Three Ashes
    Herefordshire
    Director
    Tre Ribble Barn
    HR2 8LS Three Ashes
    Herefordshire
    EnglandBritish156791110001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001

    ¿Tiene MOON 2000 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 16 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 sept 2004
    Entregado el 06 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 feb 2001
    Entregado el 20 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 20 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 mar 1998
    Entregado el 07 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 07 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0