T1M HOLDINGS (UK) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | T1M HOLDINGS (UK) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03483197 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de T1M HOLDINGS (UK) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra T1M HOLDINGS (UK) LIMITED?
Dirección de la sede social | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de T1M HOLDINGS (UK) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
IPC HOLDINGS (UK) LIMITED | 03 feb 1998 | 03 feb 1998 |
POOLTHRILL LIMITED | 18 dic 1997 | 18 dic 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de T1M HOLDINGS (UK) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para T1M HOLDINGS (UK) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Room 3-C29 Blue Fin Building 110 Southwark Street London SE1 0SU a 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR el 20 ago 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Marcus Alvin Rich como director el 13 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen John May como director el 13 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lauren Ezrol Klein como secretario el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Joseph Henry Ceryanec como director el 15 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Stanley Zieser como director el 15 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Susana D'emic como director el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Time Inc. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Modification des détails de Ipc Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 jun 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Susana D'emic como director el 07 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeffrey John Bairstow como director el 07 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Lloyd Meredith como director el 31 may 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Lauren Ezrol Klein el 28 ene 2016 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de T1M HOLDINGS (UK) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERYANEC, Joseph Henry | Director | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | Chief Financial Officer, Meredith Corporation | 243478830001 | ||||
ZIESER, John Stanley | Director | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | Cdo, Gc & Secretary, Meredith Corporation | 217687580001 | ||||
ALEY, William Robert | Secretario | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | Finance Director | 25440920002 | |||||
GORE, John Francis | Secretario | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
KLEIN, Lauren Ezrol | Secretario | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
LINDEN, Brian Andrew | Secretario | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | British | Director | 36233000002 | |||||
MCCARTHY, Robert | Secretario | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
REDPATH, John | Secretario | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
WILLIAMS, Sally Jane | Secretario | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ALEY, William Robert | Director | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | Finance Director | 25440920002 | |||||
ATKINSON, Richard Gordon | Director | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | Director | 78644420001 | |||||
AUTON, Sylvia Jean | Director | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 59045280002 | ||||
AVERILL, Howard | Director | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | Director | 127283350001 | ||||
BAILEY, Sylvia | Director | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | Chief Executive | 67232740001 | |||||
BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | Director | 181954550002 | ||||
D'EMIC, Susana Alves | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 | United States | American | Director | 265525580001 | ||||
DAVISON, Guy Bryce | Director | 128 Kensington Park Road W1 2EP London | British | Director | 48717030002 | |||||
EVANS, Richard John | Director | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | Director | 77303490001 | ||||
EVANS, Sylvia Kathleen | Director | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | Director | 70941240001 | ||||
LINDEN, Brian Andrew | Director | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | Director | 36233000002 | ||||
LINDEN, Brian Andrew | Director | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | Director | 36233000002 | ||||
MAIR, Denise Margaret | Director | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | Director | 99076200001 | ||||
MATTHEW, Michael | Director | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | Director | 40092920001 | |||||
MAY, Stephen John | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United Kingdom | British | Director | 173367920001 | ||||
MEREDITH, Charles Lloyd | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | Director | 189455000001 | ||||
MUNTON, Richard James | Director | The Forge Hamptons TN11 9RE Tonbridge Kent | British | Director | 11882410003 | |||||
RICH, Marcus Alvin | Director | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | Director | 185688190001 | ||||
ROSEN, Howard Norman | Director | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | Director | 111282190001 | ||||
WEBSTER, Evelyn Ann | Director | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | Director | 68847920003 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de T1M HOLDINGS (UK) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipc Group Limited | 04 jun 2016 | 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29, Blue Fin Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Time Inc. | 06 abr 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene T1M HOLDINGS (UK) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 13 ago 1999 Entregado el 02 sept 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Creado el 12 oct 1998 Entregado el 15 oct 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 19 ene 1998 Entregado el 06 feb 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities of the company (formerly known as poolthrill limited)to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0