TI MAGAZINES (UK) LIMITED

TI MAGAZINES (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTI MAGAZINES (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03483202
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6th Floor 60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IPC MAGAZINES (UK) LIMITED03 feb 199803 feb 1998
    EXCESSTOP LIMITED18 dic 199718 dic 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 03 mar 2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 02/03/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 02 mar 2020

    • Capital: GBP 30,140.6603
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 feb 2018

    • Capital: GBP 301,406,602
    8 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2018 au 30 jun 2019

    1 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor 161 Marsh Wall London E14 9AP England a 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR el 20 ago 2018

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    18 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name11 jun 2018

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 11 jun 2018

    RES15

    Cese del nombramiento de Lauren Ezrol Klein como secretario el 31 ene 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Marcus Alvin Rich como director el 13 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen John May como director el 13 mar 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Joseph Henry Ceryanec como director el 15 feb 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr John Stanley Zieser como director el 15 feb 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Susana D'emic como director el 31 ene 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    15 páginasAA

    Modification des détails de Time Uk Publishing Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 jun 2016

    2 páginasPSC05

    Notification de Time Inc. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    ¿Quiénes son los directivos de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CERYANEC, Joseph Henry
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    Director
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    United StatesAmerican243478830001
    ZIESER, John Stanley
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    Director
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    United StatesAmerican217687580001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Secretario
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Secretario
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    KLEIN, Lauren Ezrol
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    Secretario
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    British127397780001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Secretario
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    British36233000002
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Secretario
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Secretario
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Secretario
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Director
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Director
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    British78644420001
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Director
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Director
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsa127283350001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Director
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    British67232740001
    BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr.
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Director
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    UsaAmerican181954550002
    D'EMIC, Susana Alves
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Director
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United StatesAmerican265525580001
    DAVISON, Guy Bryce
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    Director
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    British48717030002
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Director
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Director
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew Zealander70941240001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Director
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Director
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    MAIR, Denise Margaret
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    Director
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    United KingdomBritish99076200001
    MATTHEW, Michael
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    Director
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    British40092920001
    MAY, Stephen John
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Director
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish173367920001
    MEREDITH, Charles Lloyd
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Director
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritish189455000001
    MUNTON, Richard James
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    Director
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    British11882410003
    RICH, Marcus Alvin
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Director
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    EnglandBritish185688190001
    ROSEN, Howard Norman
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Director
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    UsaUsa111282190001
    WEBSTER, Evelyn Ann
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    Director
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    EnglandBritish68847920003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Time Uk Publishing Holdings Limited
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    04 jun 2016
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroUnited Kingdom Companies House
    Número de registro4203872
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Time Inc.
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    06 abr 2016
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    No
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroState Of Delaware, Usa
    Autoridad legalState Of Delaware, Usa
    Lugar de registroState Of Delaware, Usa
    Número de registro13-3486363
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene TI MAGAZINES (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 13 ago 1999
    Entregado el 02 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998)
    Creado el 12 oct 1998
    Entregado el 15 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 ene 1998
    Entregado el 06 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of the company(formerly known as excesstop limited) to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0