PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03483521 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?
Dirección de la sede social | Unit 1 & 2 Sawmills End Barnwood Gloucester |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2016 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2017 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 nov 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Building C Imperial Gate Business Park Corinium Avenue Barnwood Gloucester GL4 3HX a Unit 1 & 2 Sawmills End Barnwood Gloucester el 02 dic 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 sept 2015
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Estado de capital el 24 sept 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Joseph Scott Etzler como director el 01 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Todd Brian Strubbe como director el 01 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Jan Dutton Madsen como director el 01 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Michael Mendlik como director el 01 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSMAN, David Charles | Secretario | Miracle Hills Drive Omaha 11808 Nebraska 68154 Usa | British | 159231890001 | ||||||
BARKER, Thomas Bernard | Director | Miracle Hills Drive Omaha 11808 Nebraska 68154 Usa | Usa | American | Company Director | 93201870005 | ||||
BERGER, Nancee Renee | Director | Miracle Hills Drive Omaha 11808 Nebraska 68154 Usa | Usa | American | Company Director | 118155860002 | ||||
ETZLER, Joseph Scott | Director | Sawmills End Barnwood Unit 1 & 2 Gloucester United Kingdom | Usa | American | President | 197073400001 | ||||
MADSEN, Jan Dutton | Director | Sawmills End Barnwood Unit 1 & 2 Gloucester United Kingdom | United States | American | Chief Financial Officer | 195930650001 | ||||
BHULLAR, Ujjal Simon | Secretario | The Gables 1 Wigton Chase Alwoodley LS17 8SG Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 24910480002 | |||||
BROOK, John Anthony | Secretario | 2 Coggan Way Bishopthorpe YO23 2QX York | British | 38922990001 | ||||||
SUTTON, Kirsty Jayne | Secretario | 8 The Beeches Pool In Wharfedale LS20 9EJ Leeds West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 116029280003 | |||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
BHULLAR, Amardip Singh | Director | 4 Fern Croft Scarcroft LS14 3JN Leeds West Yorkshire | England | British | Company Director | 64136800004 | ||||
BHULLAR, Ujjal Simon | Director | The Gables 1 Wigton Chase Alwoodley LS17 8SG Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 24910480002 | |||||
GILLINGWATER, Geoffrey Andrew | Director | 285 Woodfield Road Bilton HG1 4JQ Harrogate North Yorkshire | British | Technical Director | 74374740001 | |||||
KELLY, Lee | Director | 60 Nab Wood Road BD18 4AG Shipley | England | British | Director | 116161820001 | ||||
LINFOOT, Kevin William | Director | Bishopthorpe Garth Sim Balk Lane Bishopthorpe YO23 2UE York North Yorkshire | England | British | Director | 51219600001 | ||||
MAY, Neil Alistair | Director | Orchard Spring Ripley Road HG5 9BY Knaresborough North Yorkshire | England | British | Director | 116016450001 | ||||
MENDLIK, Paul Michael | Director | Miracle Hills Drive 68154 Omaha 11808 Nebraska Usa | Usa | Usa | Director | 166934630001 | ||||
PATTON, Stephen Francis | Director | Laurel Bank 32 Whitsbury Road SP6 1JZ Fordingbridge Hampshire | England | British | Company Director | 109947090001 | ||||
PICKETS, Gavin | Director | 41 Old Pasture Road Frimley GU16 5RT Camberley Surrey | British | Sales | 70978960001 | |||||
RAWLES, Graham Alan | Director | 80 Robin Hood Way RG41 5JN Winnersh Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 97834150001 | ||||
ROBINSON, Niklas Robert | Director | 3 Ullswater Drive LS22 6YF Wetherby West Yorkshire | English | Operations Director | 52615960001 | |||||
SMALLPAGE, Paul | Director | Maryland House 5 Grosvenor Road LS6 2DZ Leeds 2 United Kingdom | British | Sales Director | 131580370001 | |||||
STRUBBE, Todd Brian | Director | Miracle Hills Drive Omaha 11808 Nebraska 68154 Usa | Usa | American | Company Director | 159232530001 | ||||
SUTTON, Kirsty Jayne | Director | 8 The Beeches Pool In Wharfedale LS20 9EJ Leeds West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 116029280003 | ||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Uc Limited | 06 abr 2016 | Sawmills End Barnwood GL4 3DL Gloucester Unit 1 & 2 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Charge of deposit | Creado el 01 ago 2006 Entregado el 16 ago 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit initially of £200,000 credited to account designation number 33565147 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 06 jul 2006 Entregado el 21 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from dwco 6 limited to the outgoing vendors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed and floating charge | Creado el 06 jul 2006 Entregado el 18 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 20 feb 2001 Entregado el 24 feb 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed and the lease dated 9TH december 1998 (as defined) | |
Breve descripción A first equitable charge over the deposit balance (as defined) of £5750 paid into the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 23 nov 1999 Entregado el 06 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0