PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED

PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03483521
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit 1 & 2 Sawmills End
    Barnwood
    Gloucester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2016
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2017
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 24 nov 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    26 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 dic 2015

    Estado de capital el 15 dic 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Building C Imperial Gate Business Park Corinium Avenue Barnwood Gloucester GL4 3HX a Unit 1 & 2 Sawmills End Barnwood Gloucester el 02 dic 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    20 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 sept 2015

    • Capital: GBP 5,706,466.00
    4 páginasSH01

    Estado de capital el 24 sept 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Nombramiento de Mr Joseph Scott Etzler como director el 01 abr 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Todd Brian Strubbe como director el 01 abr 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Jan Dutton Madsen como director el 01 mar 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Michael Mendlik como director el 01 mar 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 24 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 dic 2014

    Estado de capital el 02 dic 2014

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 dic 2013

    Estado de capital el 12 dic 2013

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MUSSMAN, David Charles
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Secretario
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    British159231890001
    BARKER, Thomas Bernard
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Director
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director93201870005
    BERGER, Nancee Renee
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Director
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director118155860002
    ETZLER, Joseph Scott
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    Director
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    UsaAmericanPresident197073400001
    MADSEN, Jan Dutton
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    Director
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Financial Officer195930650001
    BHULLAR, Ujjal Simon
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director24910480002
    BROOK, John Anthony
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    Secretario
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    British38922990001
    SUTTON, Kirsty Jayne
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant116029280003
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BHULLAR, Amardip Singh
    4 Fern Croft
    Scarcroft
    LS14 3JN Leeds
    West Yorkshire
    Director
    4 Fern Croft
    Scarcroft
    LS14 3JN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director64136800004
    BHULLAR, Ujjal Simon
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director24910480002
    GILLINGWATER, Geoffrey Andrew
    285 Woodfield Road
    Bilton
    HG1 4JQ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    285 Woodfield Road
    Bilton
    HG1 4JQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishTechnical Director74374740001
    KELLY, Lee
    60 Nab Wood Road
    BD18 4AG Shipley
    Director
    60 Nab Wood Road
    BD18 4AG Shipley
    EnglandBritishDirector116161820001
    LINFOOT, Kevin William
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    Director
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector51219600001
    MAY, Neil Alistair
    Orchard Spring
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    North Yorkshire
    Director
    Orchard Spring
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector116016450001
    MENDLIK, Paul Michael
    Miracle Hills Drive
    68154 Omaha
    11808
    Nebraska
    Usa
    Director
    Miracle Hills Drive
    68154 Omaha
    11808
    Nebraska
    Usa
    UsaUsaDirector166934630001
    PATTON, Stephen Francis
    Laurel Bank
    32 Whitsbury Road
    SP6 1JZ Fordingbridge
    Hampshire
    Director
    Laurel Bank
    32 Whitsbury Road
    SP6 1JZ Fordingbridge
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director109947090001
    PICKETS, Gavin
    41 Old Pasture Road
    Frimley
    GU16 5RT Camberley
    Surrey
    Director
    41 Old Pasture Road
    Frimley
    GU16 5RT Camberley
    Surrey
    BritishSales70978960001
    RAWLES, Graham Alan
    80 Robin Hood Way
    RG41 5JN Winnersh
    Berkshire
    Director
    80 Robin Hood Way
    RG41 5JN Winnersh
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director97834150001
    ROBINSON, Niklas Robert
    3 Ullswater Drive
    LS22 6YF Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    3 Ullswater Drive
    LS22 6YF Wetherby
    West Yorkshire
    EnglishOperations Director52615960001
    SMALLPAGE, Paul
    Maryland House 5 Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    2
    United Kingdom
    Director
    Maryland House 5 Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    2
    United Kingdom
    BritishSales Director131580370001
    STRUBBE, Todd Brian
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Director
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director159232530001
    SUTTON, Kirsty Jayne
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant116029280003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sawmills End
    Barnwood
    GL4 3DL Gloucester
    Unit 1 & 2
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Sawmills End
    Barnwood
    GL4 3DL Gloucester
    Unit 1 & 2
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02775270
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of deposit
    Creado el 01 ago 2006
    Entregado el 16 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £200,000 credited to account designation number 33565147 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 06 jul 2006
    Entregado el 21 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from dwco 6 limited to the outgoing vendors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Ujjal Simon Bhullar
    Transacciones
    • 21 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 06 jul 2006
    Entregado el 18 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 18 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 11 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 20 feb 2001
    Entregado el 24 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed and the lease dated 9TH december 1998 (as defined)
    Breve descripción
    A first equitable charge over the deposit balance (as defined) of £5750 paid into the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • St.Martins Property Investments Limited
    Transacciones
    • 24 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 nov 1999
    Entregado el 06 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0