LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)

LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 03487186
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    Dirección de la sede social
    18 Smith Square
    SW1P 3HZ London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) LIMITED22 dic 199722 dic 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    20 páginasAA

    Notification de Local Government Association en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 feb 2019

    2 páginasPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 05 dic 2019

    2 páginasPSC09

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Cllr Nicholas Darby el 01 nov 2019

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Proctor como director el 20 ago 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Cllr Nicholas Darby como director el 27 jul 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nicholas John Dixon Chard como director el 24 jul 2019

    1 páginasTM01

    Asignación de una nueva clase de acciones por una sociedad de responsabilidad ilimitada

    3 páginasSH09

    Aprobación de re-registro

    1 páginasFOA-RR

    Certificado de re-registro de Limitado a Ilimitado

    1 páginasCERT3

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    24 páginasMAR

    Re-registro de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad privada de responsabilidad ilimitada

    2 páginasRR05

    Cese del nombramiento de Clarence Cornelius Barrett como director el 08 mar 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    117 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOLLOWAY, Claire
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Secretario
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    197947830001
    DARBY, Nicholas, Cllr
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Director
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    EnglandBritish261356930001
    NEIGHBOUR, David Alan
    Harlington Way
    GU51 4AE Fleet
    Civic Offices Hart District Council
    Hants
    United Kingdom
    Director
    Harlington Way
    GU51 4AE Fleet
    Civic Offices Hart District Council
    Hants
    United Kingdom
    United KingdomBritish184778450001
    PICKUP, Sarah Jane
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Director
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    EnglandBritish202250060001
    PROCTOR, Andrew James
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Director
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    United KingdomEnglish261412110001
    SWITHENBANK, Ian Carr Fry
    68 Porchester Drive
    NE23 9QH Cramlington
    Northumberland
    Director
    68 Porchester Drive
    NE23 9QH Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritish33820940001
    DOWNS, Carolyn Grace
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Secretario
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    British165714430001
    PLATTS, Helen Jane
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Local Government House
    Secretario
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Local Government House
    British176329670001
    RANSFORD, John Anthony
    17 Saint Marys
    YO30 7DD York
    North Yorkshire
    Secretario
    17 Saint Marys
    YO30 7DD York
    North Yorkshire
    British120473470001
    REES, John
    21 The Greenway
    UB8 2PH Uxbridge
    Middlesex
    Secretario
    21 The Greenway
    UB8 2PH Uxbridge
    Middlesex
    British16258840001
    BARRETT, Clarence Cornelius, Councillor
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Director
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    United KingdomBritish236911420001
    BRISCOE, Brian Anthony
    257 Boxley Road
    ME14 2AS Maidstone
    Temple House
    Kent
    Director
    257 Boxley Road
    ME14 2AS Maidstone
    Temple House
    Kent
    EnglandBritish56159320004
    CHARD, Nicholas John Dixon
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Director
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    United KingdomBritish94511710001
    COEN, Paul
    The Russetts
    Mayes Lane
    CM3 4NJ Danbury
    Essex
    Director
    The Russetts
    Mayes Lane
    CM3 4NJ Danbury
    Essex
    British114793600001
    DOWNS, Carolyn Grace
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Director
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish165498040001
    GEE, Ronald Stanley
    35 Gadesden Road
    West Ewell
    KT19 9LB Epsom
    Surrey
    Director
    35 Gadesden Road
    West Ewell
    KT19 9LB Epsom
    Surrey
    British43475450001
    HANNINGFIELD, The Lord, The Rt Hon
    Pippins Place
    Helmons Lane, West Hanningfield
    CM2 8UW Chelmsford
    Essex
    Director
    Pippins Place
    Helmons Lane, West Hanningfield
    CM2 8UW Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish77930920001
    HUGHES, Stephen Edward
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Director
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    United KingdomBritish112164350001
    JACKSON, Anthony Peter
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Director
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish140431600001
    JONES, Harry, Sir
    8 Beaufort Place
    NP9 7NB Newport
    Gwent
    Director
    8 Beaufort Place
    NP9 7NB Newport
    Gwent
    WalesBritish16605380001
    JONES, Stephen William
    1 Sanger Drive
    Send
    GU23 7EB Woking
    Surrey
    Director
    1 Sanger Drive
    Send
    GU23 7EB Woking
    Surrey
    United KingdomBritish123054070001
    LAMBERT, Claire
    Starveall Farm
    Oxford Road Stone
    HP17 8PZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Starveall Farm
    Oxford Road Stone
    HP17 8PZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish101232430001
    MITCHELL, Keith Ronald
    New Road
    OX17 3NU Oxford
    Leaders Office County Hall
    Oxfordshire
    Director
    New Road
    OX17 3NU Oxford
    Leaders Office County Hall
    Oxfordshire
    United KingdomBritish136157500001
    NAYLOR, Adrian
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Director
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish199102380001
    ROE, Philippa Marion, Cllr
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Director
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish131976560001
    THORNBER, Thomas Kenneth, Councillor
    Back Lane
    Sway
    SO41 6BU Lymington
    Myrtle Cottage
    Hampshire
    Britain
    Director
    Back Lane
    Sway
    SO41 6BU Lymington
    Myrtle Cottage
    Hampshire
    Britain
    EnglandBritish184079310001
    THORNTON, James Douglas
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Director
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish72854560001
    WHITE, Christopher, Councillor
    17 Cunningham Avenue
    AL1 1JJ St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    17 Cunningham Avenue
    AL1 1JJ St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish102094030002
    WHITEMAN, Milner, Cllr
    Arlescott Farm
    TF12 5BG Broseley
    Shropshire
    Director
    Arlescott Farm
    TF12 5BG Broseley
    Shropshire
    British86513060001
    WHITHAM, Graham George, Councillor
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Director
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish203071600001
    WILLIAMS, David Reeve, Sir
    8 Arlington Road
    Petersham
    TW10 7BY Richmond
    Surrey
    Director
    8 Arlington Road
    Petersham
    TW10 7BY Richmond
    Surrey
    EnglandBritish16773620001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    17 feb 2019
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Company Without Share Capital
    País de registroUk
    Autoridad legalCompay Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro11177145
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    08 nov 201619 feb 2019La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge
    Creado el 21 ene 2000
    Entregado el 25 ene 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement or any hedging agreements (as defined in the loan agreement dated 20TH january 2000)
    Breve descripción
    Local government house (formerly transport house) smith square london t/no NGL374544 with all fixed plant & machinery and fixtures thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 2000Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 26 mar 1999
    Entregado el 10 abr 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 22ND january 1998
    Breve descripción
    The whole of the land and buildings thereon at smith square london SW1 t/n NGL374544 the whole of the company's undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personas con derecho
    • Association of Metropolitan Authorities (Properties) Limited
    Transacciones
    • 10 abr 1999Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 22 ene 1998
    Entregado el 05 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a transport house smith square london SW1 t/no;-NGL374544 the proceeds of sale thereof goodwill benefit of all licences. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transacciones
    • 05 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 ene 1998
    Entregado el 05 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transacciones
    • 05 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 22 ene 1998
    Entregado el 27 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,900,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Transport house smith square westminster london.
    Personas con derecho
    • Bernard Passingham
    • Charles Bernard Pitson
    • Raymond Frank Deaves
    Transacciones
    • 27 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 16 dic 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 ene 1998
    Entregado el 24 ene 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an agreement dated 22ND january 1998
    Breve descripción
    The whole of the land and buildings at smith square london t/no NGL374544 and a floating charge the undertaking property and assets.
    Personas con derecho
    • Acc Properties Limited
    Transacciones
    • 24 ene 1998Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0