MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED

MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03488633
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MEDOMSLEY SECURE TRAINING SERVICES LIMITED13 mar 199813 mar 1998
    ALNERY NO. 1734 LIMITED05 ene 199805 ene 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cambio de datos del director Mr Philip Peter Ashbrook el 01 may 2016

    2 páginasCH01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 01 jun 2016

    20 páginasRP04

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 jun 2016

    Estado de capital el 06 jun 2016

    • Capital: GBP 200,000
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    16 jun 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 16/06/2016.

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 17 feb 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr John Ivor Cavill como director el 25 ene 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Biif Corporate Services Limited como director el 25 ene 2016

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Biif Corporate Services Limited el 01 jul 2015

    1 páginasCH02

    Domicilio social registrado cambiado de , C/O Dundas & Wilson, Northwest Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ a Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF el 01 jul 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jun 2015

    Estado de capital el 17 jun 2015

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Philip Peter Ashbrook el 01 sept 2014

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Philip Peter Ashbrook como director el 25 jul 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard David Hoile como director el 25 jul 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jun 2014

    Estado de capital el 18 jun 2014

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    17 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de , C/O Dundas & Wilson, North West Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ el 27 ago 2013

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    17 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro05372427
    128530180002
    ASHBROOK, Philip Peter
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    Director
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish121252960004
    BALDOCK, Graham
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Director
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish49519600001
    CAVILL, John Ivor
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Director
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    EnglandBritish152521640008
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Secretario
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    British56835390001
    COOKE, David John
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    Secretario
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    British83213800001
    MOORE, William Edmond
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    British114630630002
    TODD, Francesca Anne
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    Secretario
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    British72249980001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secretario designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BAILEY, Carol Elaine
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    Director
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    British93650840001
    BAILEY, Carol Elaine
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    Director
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    EnglandBritish9905530001
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Director
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    United KingdomBritish56835390001
    CALABRESE, Wayne Howard
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    Director
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    United StatesAmerican30780670003
    CARTER, James Duncan
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    Director
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    British93908800001
    CORNWELL, Anthony Bruce
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    Director
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish3471920001
    CRAWSHAW, Andrew Julian
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    Director
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    EnglandBritish130322170001
    EDWARDS, Philip John
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    Director
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    British87032350001
    FUTCHER, William Frank
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    British51346890001
    HAGA, Thomas Justin
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    Director
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    United KingdomBritish111282640001
    HAYWARD, Neil
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    British144924760001
    HILL, Gavin
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Director
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish84457250005
    HOILE, Richard David
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing Bush House
    United Kingdom
    Director
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing Bush House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137848430002
    JEFFERY, John Daniel Michael
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    Director
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    British93851850002
    KEENS, Donald Herbert
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    Director
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    British70256340003
    LEACH, Guy William
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    Director
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    British70877660003
    LEWIS, Kevin Tony
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Director
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Australian86468730001
    LEWIS, Kevin Tony
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Director
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Australian52036330001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Director
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MCNAUGHT, William Wright
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    Director
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    British52531510002
    MEAD, Mark William
    28 The Burlings
    SL5 8BY Ascot
    Berkshire
    Director
    28 The Burlings
    SL5 8BY Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish151850410001
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish156912990001
    REICHERTER, Matthias Alexander
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomGerman138502740001
    RIALL, Thomas Richard Phineas
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Director
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish76434190002
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Director
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SMITH, John
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    Director
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    British95897660001

    ¿Tiene MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security assignment
    Creado el 02 dic 2006
    Entregado el 07 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from pcfl to the security trustee and the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the company's right,title and interest,present and future,in.under and to the relevant contract. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 2006Registro de un cargo (395)
    Deed of release and counter-indemnity
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 03 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the senior charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Banks
    Transacciones
    • 03 oct 2003Registro de un cargo (395)
    Deed of release and counter-indemnity
    Creado el 17 sept 2003
    Entregado el 03 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the subordinated charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Serco Investments Limited as Subordinated Security Trustee on Behalf of the Lenders
    Transacciones
    • 03 oct 2003Registro de un cargo (395)
    A subordinated fixed and floating charge
    Creado el 12 nov 1998
    Entregado el 27 nov 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under each or any of the financing agreements
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Serco Investments Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 27 nov 1998Registro de un cargo (395)
    Deed of fixed charge
    Creado el 12 nov 1998
    Entregado el 20 nov 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement of even date ("the dcmf contract")
    Breve descripción
    All the companys right title and interest in and to the equipment (as defined therein).
    Personas con derecho
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department
    Transacciones
    • 20 nov 1998Registro de un cargo (395)
    Fixed and floating charge
    Creado el 12 nov 1998
    Entregado el 25 nov 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the agent) under each or any of the financing agreements
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 nov 1998Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0