GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED

GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03493652
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Acre House
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HEALTHGATE (MID ESSEX) PARKING LTD12 feb 199812 feb 1998
    HEATHGATE (MID ESSEX) PARKING LTD05 feb 199805 feb 1998
    EXTRACT LIMITED16 ene 199816 ene 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    7 páginasAA

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019

    9 páginasAA

    Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 3

    5 páginasMR05

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Pierre Stephane Marc Banon como director el 05 dic 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sabrina Sidhu como director el 05 dic 2018

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Graham Maurice Beazley Long el 29 jun 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Sabrina Sidhu como director el 10 oct 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Benjamin Christopher Jacob Dean como director el 10 oct 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2016

    14 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FITZSIMMONS, Stefan, Mr.
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Secretario
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    English103270770005
    BANON, Pierre Stephane Marc
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Innisfree Ltd, 1st Floor, Boundary House, 91/93
    England
    Director
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Innisfree Ltd, 1st Floor, Boundary House, 91/93
    England
    EnglandFrench,BritishPortfolio Manager252215620001
    BEAZLEY LONG, Graham Maurice
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    1st Floor, Boundary House
    England
    Director
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    1st Floor, Boundary House
    England
    EnglandEnglishInvestment Management Director47569660007
    ALWIS, Mewan
    Green Island Lodge Hillside Road
    HA5 3YJ Pinner Hill
    Middlesex
    Secretario
    Green Island Lodge Hillside Road
    HA5 3YJ Pinner Hill
    Middlesex
    British157112310001
    EKINS, Nicholas Kethro
    25 Gainsborough Road
    IP4 2XG Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    25 Gainsborough Road
    IP4 2XG Ipswich
    Suffolk
    British61441280003
    FERNANDES, Milton Anthony
    Wisteria House
    67 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    Secretario
    Wisteria House
    67 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    British108927700001
    SEMKEN LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretario designado corporativo
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005970001
    BEADELL, Stewart Alan
    93 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    Director
    93 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    BritishChartered Surveyor64625700001
    DEAN, Benjamin Christopher Jacob
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    Director
    91/93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    England
    United KingdomBritishInvestment Director225247590001
    EDMONSTON, Roger
    Alandale Houghton Avenue
    Hempstead
    ME7 3RY Gillingham
    Kent
    Director
    Alandale Houghton Avenue
    Hempstead
    ME7 3RY Gillingham
    Kent
    BritishDirector7974110001
    EDWARDS, Matthew James
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    91/93
    England
    Director
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    91/93
    England
    EnglandBritishInvestment Director180522620001
    EDWARDS, Matthew James
    Gutter Lane
    EC2V 8AS London
    33
    United Kingdom
    Director
    Gutter Lane
    EC2V 8AS London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishPortfolio Manager155187990001
    EKINS, Nicholas Kethro
    25 Gainsborough Road
    IP4 2XG Ipswich
    Suffolk
    Director
    25 Gainsborough Road
    IP4 2XG Ipswich
    Suffolk
    BritishChartered Surveyor61441280003
    FERNANDES, Milton Anthony
    Wisteria House
    67 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    Director
    Wisteria House
    67 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector108927700001
    FERNANDES, Milton Anthony
    Wisteria House
    67 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    Director
    Wisteria House
    67 Kingston Lane
    TW11 9HN Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector108927700001
    FINEGAN, Andrea
    45 Boyne Road
    Lewisham
    SE13 5AL London
    Director
    45 Boyne Road
    Lewisham
    SE13 5AL London
    GermanFund Manager65514200008
    PEARSON, Timothy Richard
    SE9
    Director
    SE9
    EnglandBritishDirector46889670002
    PESSKIN, Robin Michael
    Bushey Cottage
    172 High Road
    WD25 7DT Bushey Heath Watford
    Hertfordshire
    Director
    Bushey Cottage
    172 High Road
    WD25 7DT Bushey Heath Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Director65641850004
    SHEEHAN, Richard Keith
    Flat 9 Old Swan Wharf
    116 Battersea Church Road
    SW11 3NA London
    Director
    Flat 9 Old Swan Wharf
    116 Battersea Church Road
    SW11 3NA London
    United KingdomEnglishPortfolio Manager117776240001
    SIDHU, Sabrina
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House 91/93
    England
    Director
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House 91/93
    England
    EnglandBritishInvestment Director238179460001
    SILVER, Mervyn Scott
    Flat 4
    7 Gordon Avenue
    HA7 3QE Stanmore
    Director
    Flat 4
    7 Gordon Avenue
    HA7 3QE Stanmore
    EnglandBritishAccountant94767020001
    LUFMER LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Director designado corporativo
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005960001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Gentian Holdings Limited
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    06 abr 2016
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalUk Law
    Lugar de registroRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Número de registro03408538
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene GENTIAN (MID-ESSEX) PARKING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 24 may 2002
    Entregado el 27 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property k/a all that land attached to the headlease of car parks at broomfield hospital chelmsford (as further defined therein). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 15 may 2002
    Entregado el 22 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Car parks at broomfield hospital chelmsford t/n EX670831. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2020Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 19 mar 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge or agreement
    Creado el 07 abr 1998
    Entregado el 17 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The agreement dated 23 february 1998 between the company and mid essex hospital services national health service trust including the company's interest in the property all contracts for sale or lease of the property all plant machinery fixtures fittings furniture equipment etc and the proceeds of any insurance.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 07 abr 1998
    Entregado el 17 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2021Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0