CLAVERHAM 98 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLAVERHAM 98 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03495314
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLAVERHAM 98 LIMITED?

    • fabricación de otras maquinarias de propósito especial n.c.o.p. (28990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CLAVERHAM 98 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLAVERHAM 98 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OVAL (1261) LIMITED20 ene 199820 ene 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLAVERHAM 98 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CLAVERHAM 98 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLAVERHAM 98 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    Resolución de insolvencia

    Resolution insolvency:res re statement of account
    1 páginasLIQ MISC RES

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Claverham Limited Bishops Road Claverham BS49 4NF

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Claverham Bristol BS49 4NF a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 05 sept 2014

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Nombramiento de Mr Evan Francis Smith como director el 16 jul 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Christian Bruno Jean Idczak-Descat como director el 16 jul 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Rajinder Singh Kullar como director el 16 jul 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andreas Schell como director el 16 jul 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Roger Robert Charles Buxton como director el 06 abr 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Andrew Fowler como director el 16 jul 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 ene 2014

    Estado de capital el 24 ene 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2012

    15 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 02 jul 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH01

    Estado de capital el 09 jul 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium acc of £39062000 cancelled 03/07/2013
    RES13

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 28 jun 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    ¿Quiénes son los directivos de CLAVERHAM 98 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EDWIN COE SECRETARIES LIMITED
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroOC326366
    139113140001
    IDCZAK, Christian Bruno Jean
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandFrench129935690010
    KULLAR, Rajinder Singh
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Director
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Untied KingdomBritish74999290008
    SMITH, Evan Francis
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Director
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican,Irish73647690004
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Secretario
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Secretario
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    British77864400001
    MCCARTHY, Richard Thomas
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    Secretario
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    American128751220001
    PACKHAM, Robert William
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    Secretario
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    British137923770001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secretario designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    BEAN, Alan David
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    Director
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    British66656720002
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Director
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    BUXTON, Roger Robert Charles
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    Director
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    United KingdomBritish78210300002
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Director
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    EnglandBritish77864400001
    FOWLER, Peter Andrew
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    Director
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    United KingdomBritish241110830001
    FROST, Simon Richard
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    Director
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    British87291390001
    GARDINER, Michael Charles
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    Director
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    United KingdomUk172073870001
    GINGRICH, James Lee
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Director
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Us Citizen77865030001
    LEDUC, Robert Francis
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    Director
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    UsaUs Citizen103629560001
    SAXE, Thomas William
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    Director
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    UsaAmerican155680740001
    SCHELL, Andreas
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    Director
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    UsaGerman176150890001
    WHYBROW, Ian Michael
    Badgers
    Cadmore End
    HP14 3PL High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    Badgers
    Cadmore End
    HP14 3PL High Wycombe
    Buckinghamshire
    British43349720001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Director designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Director designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    ¿Tiene CLAVERHAM 98 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of assignment of life policies
    Creado el 04 mar 1998
    Entregado el 11 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and liabilities which shall for the time being be due from owing or incurred to each beneficiary by the company or by any group company under or pursuant to the finance documents
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the policies re: simon frost £500,000 policy no: 3633347K. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 23 ene 1998
    Entregado el 06 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the "principal debtors" (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and all other charges and expenses subject at all times to the provisions of the senior finance documents (as defined in the facilities agreement dated 23 january 1998 (as defined))
    Breve descripción
    All moneys at the date of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books by way of fixed and specific charge.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 23 ene 1998
    Entregado el 06 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transacciones
    • 06 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CLAVERHAM 98 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 ago 2014Inicio de la liquidación
    06 jun 2015Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0