COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | 03498808 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
- Actividades auxiliares a la intermediación financiera n.c.o.p. (66190) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
| Dirección de la sede social | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COMPUTERSHARE SERVICES PLC | 25 feb 1998 | 25 feb 1998 |
| CORPORATE REGISTRY SERVICES PLC | 20 ene 1998 | 20 ene 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025 | 45 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 48 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de David Nugent como director el 31 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Llewellyn Kevan Botha como secretario el 25 ene 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 47 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 47 páginas | AA | ||
Cessation de Computershare Investments (Uk) (No. 3) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 oct 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Computershare Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 oct 2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Nombramiento de Mr David Nugent como director el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Christopher Pears como director el 30 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Richard David Morphey como director el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de James Terence Hood como director el 30 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Mr Llewellyn Kevan Botha el 06 abr 2022 | 1 páginas | CH03 | ||
Cese del nombramiento de Llewellyn Kevan Botha como director el 10 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 49 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Ralph Gordon Barber el 01 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Ralph Gordon Barber el 01 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Jonathan Michael Pattinson como director el 17 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Judith Mary Matthews como secretario el 21 sept 2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Dolbear como secretario el 23 jul 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Steffen Herfurth como director el 30 jun 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTHEWS, Judith Mary | Secretario | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | 287487280001 | |||||||
| AU, Wai-Fong | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British | 169305040001 | |||||
| BARBER, Ralph Gordon | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British | 200869440001 | |||||
| BRAITHWAITE, Philip Charles | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | United Kingdom | British | 200872880001 | |||||
| PATTINSON, Jonathan Michael | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British | 196784290001 | |||||
| PEARS, Christopher | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British | 261112330002 | |||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Secretario | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | South African | 105560560001 | ||||||
| CORNEY, Darryl John | Secretario | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | 83564940010 | ||||||
| DOLBEAR, Jonathan | Secretario | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | 161908600001 | |||||||
| LEIPER, Julian Guthrie | Secretario | 55 Great King Street EH3 6RP Edinburgh | British | 52848130001 | ||||||
| WALES, Anthony Norman | Secretario | 21 Pymble Avenue Pymble Sydney FOREIGN New South Wales 2073 Australia | Australian | 55910880001 | ||||||
| WALLACE, Barbara Charlotte | Secretario | 180 Springfield Road EH49 7JT Linlithgow West Lothian | British | 59091840002 | ||||||
| ALLEN, Peter Richard | Director | 38 Blunts Wood Road RH16 1NB Haywards Heath West Sussex | England | British | 20061750001 | |||||
| APPLEBY, Lynn | Director | 87 Birchall Road BS6 7TT Bristol | British | 62475630002 | ||||||
| ARBERRY, Richard | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British | 170004380001 | |||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Director | BS9 1HD Bristol 22 Cranleigh Gardens England | England | South African | 105560560002 | |||||
| BRAASCH, Jochen | Director | Chandos Woodfield Road Redland BS6 6PL Bristol Apt Number 15 England | England | German | 153472260001 | |||||
| CHAPMAN, Robert William Frederick | Director | Lough Beltra 76 Lymington Bottom, Four Marks GU34 5AH Alton Hampshire | United Kingdom | British | 110216200001 | |||||
| CORNEY, Darryl John | Director | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British | 83564940010 | |||||
| CROSBY, William Stuart | Director | 705 Tead Froad Shad Thames SE1 2AS London | Australian | 108681440001 | ||||||
| DRAKE, Martyn William | Director | Westbury Park BS6 7JB Bristol 7 England | England | English | 204526200001 | |||||
| DRAKE, Martyn William | Director | 10 Brecon Road BS9 4DS Bristol | British | 70285460002 | ||||||
| ELLIOTT, Mark Edward | Director | C/O Computershare 7th Floor Jupiter House 14 Finsbury Square EC2A 1BR London | Australian | 66676160001 | ||||||
| HERFURTH, Steffen | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | Germany | German | 147417150001 | |||||
| HOLLEYOAK, Christopher | Director | 68 Brackendown Avenue DT3 6HX Weymouth Dorset | England | British | 88500920001 | |||||
| HOOD, James Terence | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | Wales | British | 189833420002 | |||||
| HOOD, James Terence | Director | Redland Road BS6 6YA Bristol 140b Avon United Kingdom | England | British | 189833420001 | |||||
| LEIPER, Julian Guthrie | Director | 55 Great King Street EH3 6RP Edinburgh | Scotland | British | 52848130001 | |||||
| MACLAGAN, Penelope | Director | 2/655 Victoria Street 3067 Abbotsford Victoria Australia | Australian | 58807930001 | ||||||
| MILLS, Christopher Andrew | Director | Park Lane Blagdon BS40 7SB Bristol Heronmere England | England | British | 178211930001 | |||||
| MORPHEY, Richard David | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | England | British | 261116510001 | |||||
| MORRIS, Christopher John | Director | 608 Spice Quay Heights 32 Shad Thames SE1 2YL London | Australia | Australian | 114812600001 | |||||
| MORRISON, Thomas Vance | Director | 17 East Barnton Gardens EH4 6AR Edinburgh | British | 1024220002 | ||||||
| NUGENT, David | Director | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | Canada | British | 297529020001 | |||||
| OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert | Director | Holt Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill BS40 8QR Chew Magna Greenleigh Farm Bristol England | England | British | 116701010001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES PLC?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computershare Limited | 21 oct 2022 | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Computershare Investments (Uk) (No. 3) Limited | 08 abr 2016 | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0