RINGWAY HOTELS LIMITED

RINGWAY HOTELS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRINGWAY HOTELS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03502987
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RINGWAY HOTELS LIMITED?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra RINGWAY HOTELS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bewleys Hotel Outwood Lane
    Manchester Airport
    M90 4HL Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RINGWAY HOTELS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INHOCO 740 LIMITED03 feb 199803 feb 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RINGWAY HOTELS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RINGWAY HOTELS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 24 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    7 páginasAA

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2016

    17 páginasAA

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 30 jun 2015

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Karen Moran como director el 01 ene 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Tracey Moran como director el 01 ene 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de RINGWAY HOTELS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORAN, Thomas
    Whitechurch Road Upper
    Rathfarnham
    Dublin 14
    Glenwood
    Ireland
    Secretario
    Whitechurch Road Upper
    Rathfarnham
    Dublin 14
    Glenwood
    Ireland
    198582220001
    MORAN, Karen
    Ranelagh
    Dublin 6
    2 Price's Place
    D06 N902
    Ireland
    Director
    Ranelagh
    Dublin 6
    2 Price's Place
    D06 N902
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director223895550001
    MORAN, Thomas
    Upper Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Dublin
    Ireland
    Director
    Upper Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director129051610004
    MORAN, Tracey
    Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Ireland
    Director
    Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director223894440001
    ASPLE, Patrick Joseph
    Greenville
    North Parade
    IRISH Gorbey
    Wexford
    Ireland
    Secretario
    Greenville
    North Parade
    IRISH Gorbey
    Wexford
    Ireland
    IrishDirector73681430001
    KEMP, William David
    10 Brampton Road
    Bramhall
    SK7 3BS Stockport
    Cheshire
    Secretario
    10 Brampton Road
    Bramhall
    SK7 3BS Stockport
    Cheshire
    British43127660001
    MORAN, Thomas
    Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Glinwood
    Dublin
    Ireland
    Secretario
    Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Glinwood
    Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director129051610004
    O' DOHERTY, Donal
    Castleknock
    Castleknock
    7 Ashleigh Grove
    Dublin 15
    Ireland
    Secretario
    Castleknock
    Castleknock
    7 Ashleigh Grove
    Dublin 15
    Ireland
    192840530002
    TERRY, Emma Louise
    9 Oakwood Avenue
    Gatley
    SK8 4LR Cheadle
    Cheshire
    Secretario
    9 Oakwood Avenue
    Gatley
    SK8 4LR Cheadle
    Cheshire
    British43421200001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    38962110003
    ALLEN, Maurice Lancelot
    Sunbrae
    IRISH Enniscorthy
    Wexford
    Ireland
    Director
    Sunbrae
    IRISH Enniscorthy
    Wexford
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director7868570001
    ALLEN, Maurice Lancelot
    Sunbrae
    IRISH Enniscorthy
    Wexford
    Ireland
    Director
    Sunbrae
    IRISH Enniscorthy
    Wexford
    Ireland
    IrelandIrishDirector7868570001
    ALLEN, Samuel Bertram
    Enniscorthy
    Co Wexford
    Brownswood House
    Wx
    Ireland
    Director
    Enniscorthy
    Co Wexford
    Brownswood House
    Wx
    Ireland
    IrishCompany Director132695640001
    ALLEN, Samuel Bertram
    Ounavarra House
    Courtown
    IRISH Gorey
    Wexford
    Ireland
    Director
    Ounavarra House
    Courtown
    IRISH Gorey
    Wexford
    Ireland
    IrelandIrishDirector7868590001
    ASPLE, Patrick Joseph
    Greenville
    North Parade
    IRISH Gorbey
    Wexford
    Ireland
    Director
    Greenville
    North Parade
    IRISH Gorbey
    Wexford
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director73681430001
    BETHELL, James
    The Toll Barn
    Heath Road
    NR28 0JB North Walsham
    Norfolk
    Director
    The Toll Barn
    Heath Road
    NR28 0JB North Walsham
    Norfolk
    BritishManaging Director82228260001
    BURNS, Rowena
    The Manchester Airport Group Plc
    6th Floor Olympic House
    M90 1QX Manchester Airport
    Greater Manchester
    Director
    The Manchester Airport Group Plc
    6th Floor Olympic House
    M90 1QX Manchester Airport
    Greater Manchester
    BritishCompany Director107366640001
    CURRAN, Sarah Patricia
    42 Petworth Close
    M22 4YQ Manchester
    Director
    42 Petworth Close
    M22 4YQ Manchester
    IrishDirector87340710002
    EARLY, John Dalton
    Flat 510 Middle Warehouse
    Castle Quay Chester Road
    M15 4NT Manchester
    Lancashire
    Director
    Flat 510 Middle Warehouse
    Castle Quay Chester Road
    M15 4NT Manchester
    Lancashire
    BritishDirector4150930005
    LANGWALLNER, Andrew
    Tudor House
    Light Alders Lane
    SK12 2LW Disley
    Cheshire
    Director
    Tudor House
    Light Alders Lane
    SK12 2LW Disley
    Cheshire
    EnglandIrishDirector85056900001
    LEESE, Richard Charles, Sir
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    Director
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    United KingdomBritishCouncillor53459790002
    MCGREAL, William
    Castleknock
    Castleknock
    20 Farmeligh Park
    Dublin 15
    Ireland
    Director
    Castleknock
    Castleknock
    20 Farmeligh Park
    Dublin 15
    Ireland
    IrelandIrishDirector192520010001
    MELMOTH, Graham John, Sir
    Throstles Nest
    Higher Fence Road Whitney Croft
    SK10 1RQ Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Throstles Nest
    Higher Fence Road Whitney Croft
    SK10 1RQ Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishChief Executive30180970001
    MORAN, Karen
    Prices Place
    Ranelagh
    IRISH
    2
    Dublin 6
    Ireland
    Director
    Prices Place
    Ranelagh
    IRISH
    2
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishDirector91105320002
    MORAN, Michael
    Crown Moran Hotel
    142 Cricklewood Broadway
    NW2 3ED London
    The Flat
    Director
    Crown Moran Hotel
    142 Cricklewood Broadway
    NW2 3ED London
    The Flat
    EnglandIrishCompany Director129007440002
    MORAN, Sheila
    Upper Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Ireland
    Director
    Upper Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Ireland
    IrelandIrishDirector134303730011
    MORAN, Thomas James Patrick
    Baronsmede
    Ealing
    W5 4LT London
    48
    England
    Director
    Baronsmede
    Ealing
    W5 4LT London
    48
    England
    EnglandIrishDirector109923270003
    MORAN, Tracey
    Upper Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Ireland
    Director
    Upper Whitechurch Road
    Rathfarnham
    Dublin 16
    Four Seasons
    Ireland
    IrelandIrishDirector134305610004
    MUIRHEAD, Geoff
    Chorley House Row Of Trees
    Knutsford Road
    SK9 7SH Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    Chorley House Row Of Trees
    Knutsford Road
    SK9 7SH Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director148132240001
    O'DOHERTY, Donal
    Castleknock
    Castleknock
    7 Ashleigh Grove
    Dublin 15
    Ireland
    Director
    Castleknock
    Castleknock
    7 Ashleigh Grove
    Dublin 15
    Ireland
    IrelandIrishDirector192542650001
    OLDHAM, Samuel Roy
    8 Back Moor
    Mottram Longdendale
    SK14 6LF Hyde
    Cheshire
    Director
    8 Back Moor
    Mottram Longdendale
    SK14 6LF Hyde
    Cheshire
    BritishDirector6252170001
    POWER, Patrick
    Coolyduff
    Inniscarra
    Tuam Naofa
    Cork
    Ireland
    Director
    Coolyduff
    Inniscarra
    Tuam Naofa
    Cork
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director129007590001
    RIDAL, Philip Martin
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    Director
    1 Ham Street
    TW10 7HR Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant79892010001
    ROBERTS, Peter Lewis, Councillor
    18 Belmont Way
    OL12 6HR Rochdale
    Greater Manchester
    Director
    18 Belmont Way
    OL12 6HR Rochdale
    Greater Manchester
    BritishCouncillor10413990001
    SCOTT, Peter Anthony
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    Director
    6 Bowling Green Way
    Bamford
    OL11 5QQ Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector1674500002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RINGWAY HOTELS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Thomas Moran
    Outwood Lane
    Manchester Airport
    M90 4HL Manchester
    Bewleys Hotel
    04 jun 2016
    Outwood Lane
    Manchester Airport
    M90 4HL Manchester
    Bewleys Hotel
    No
    Nacionalidad: Irish
    País de residencia: Ireland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene RINGWAY HOTELS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 05 dic 2014
    Entregado el 17 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Bewleys manchester airport hotel, outwood lane, manchester.. Title no.: GM904577.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Trustee
    Transacciones
    • 17 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 26 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 16 dic 2013
    Entregado el 03 ene 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Bewleys manchester airport hotel outwood lane manchester t/no GM904577. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Trustee
    Transacciones
    • 03 ene 2014Registro de una carga (MR01)
    • 26 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 27 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor or any irish chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 27 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 26 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Security accession deed which supplements the debenture dated 14 march 2008 and
    Creado el 14 mar 2008
    Entregado el 22 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of properties charged please see image, fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (Security Agent)
    Transacciones
    • 22 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of debenture
    Creado el 31 ene 2003
    Entregado el 07 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Anglo Irsih Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 07 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 13 jun 2000
    Entregado el 17 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transacciones
    • 17 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 15 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0