WILCHAP NOMINEES LIMITED

WILCHAP NOMINEES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWILCHAP NOMINEES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03507524
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    • Notarios (69102) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o WILKIN CHAPMAN LLP
    Cartergate House
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WILCHAP 72 LIMITED10 feb 199810 feb 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta12 ene 2027
    Próxima declaración de confirmación vence26 ene 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta12 ene 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Henry Dixon como secretario el 12 ene 2026

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Hannah Emily Fowler como secretario el 12 ene 2026

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2025

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Hannah Emily Fowler como secretario el 24 oct 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Stella Dodd como secretario el 24 oct 2024

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ian Sherburn como director el 13 feb 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian Sherburn como secretario el 13 feb 2024

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Sarah Elizabeth Kemp como director el 13 feb 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Adam Daniel Andrew Ottley como director el 13 feb 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Edward George Capes como director el 13 feb 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Russell John Eke como director el 31 mar 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Pamela Carr como secretario el 14 oct 2022

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Ian Sherburn el 05 jul 2021

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Ian Sherburn el 05 jul 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael James Squirrell como director el 31 dic 2020

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DIXON, Henry
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secretario
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    344323440001
    CAPES, Edward George
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Director
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    EnglandBritish221071970001
    KEMP, Sarah Elizabeth
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Director
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    EnglandBritish297608430001
    OTTLEY, Adam Daniel Andrew
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Director
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    EnglandBritish279989670001
    BARLEY, Carol
    New Oxford House
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Secretario
    New Oxford House
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    North East Lincolnshire
    British125432310001
    CAMPBELL, Pauline
    Wilkin Chapman New Oxford House
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    South Humberside
    Secretario
    Wilkin Chapman New Oxford House
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    South Humberside
    British54895620001
    CARR, Pamela
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Secretario
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    British125342500001
    DODD, Stella
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    Lincolnshire
    Secretario
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    Lincolnshire
    British125342680001
    FOWLER, Hannah Emily
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secretario
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    328605240001
    HILLMAN, Anna Ruth
    New Oxford House Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Secretario
    New Oxford House Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    North East Lincolnshire
    British57925320001
    HOUGHTON, Christopher John
    1 Waterloo Drive
    Scartho Top
    DN33 3SQ Grimsby
    East Lincolnshire
    Secretario
    1 Waterloo Drive
    Scartho Top
    DN33 3SQ Grimsby
    East Lincolnshire
    British68376520003
    SHERBURN, Ian
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    England
    Secretario
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    England
    British73045470001
    AISTHORPE, Adam
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Director
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    United KingdomBritish163330390001
    BANTON, Daniel William
    6 Eason Road
    Scartho Top
    DN33 3SN Grimsby
    South Humberside
    Director
    6 Eason Road
    Scartho Top
    DN33 3SN Grimsby
    South Humberside
    United KingdomBritish125974480001
    CHILVERS, Martyn Douglas
    27 Ferriby Lane
    DN33 3NS Grimsby
    South Humberside
    Director
    27 Ferriby Lane
    DN33 3NS Grimsby
    South Humberside
    EnglandBritish110976710001
    CLARKE, Anna
    William Street
    Long Eaton
    NG10 4GB Nottingham
    95
    Nottinghamshire
    Director
    William Street
    Long Eaton
    NG10 4GB Nottingham
    95
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish110730900002
    DAY, Philip David
    Hillfoot
    18 Church Lane, Bonby
    DN20 0PS Brigg
    South Humberside
    Director
    Hillfoot
    18 Church Lane, Bonby
    DN20 0PS Brigg
    South Humberside
    United KingdomBritish146676420001
    EKE, Russell John
    Wilkin Champman New Oxford House
    Town Hall Square
    DN31 1HG Grimsby
    North East Lincolshire
    Director
    Wilkin Champman New Oxford House
    Town Hall Square
    DN31 1HG Grimsby
    North East Lincolshire
    United KingdomBritish56042550003
    HILLMAN, Anna Ruth
    New Oxford House Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Director
    New Oxford House Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    North East Lincolnshire
    British57925320001
    HORBURY, Caroline
    79 Minster Moorgate
    HU17 8HP Beverley
    East Yorkshire
    Director
    79 Minster Moorgate
    HU17 8HP Beverley
    East Yorkshire
    United KingdomBritish91872230001
    HOUGHTON, Christopher John
    1 Waterloo Drive
    Scartho Top
    DN33 3SQ Grimsby
    East Lincolnshire
    Director
    1 Waterloo Drive
    Scartho Top
    DN33 3SQ Grimsby
    East Lincolnshire
    British68376520003
    MCCRACKEN, Vincent Rodger Whyte
    4 Cooks Lane
    Great Coates
    DN37 9NW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Director
    4 Cooks Lane
    Great Coates
    DN37 9NW Grimsby
    North East Lincolnshire
    British65909570001
    OTTER, Jamie Edward
    31 Enderby Crescent
    DN21 1XQ Gainsborough
    Lincolnshire
    Director
    31 Enderby Crescent
    DN21 1XQ Gainsborough
    Lincolnshire
    British80118480001
    ROBINSON, Richard John
    New Oxford House Town Hall Square
    Grimsby
    DN31 1HE North East Lincolnshire
    Director
    New Oxford House Town Hall Square
    Grimsby
    DN31 1HE North East Lincolnshire
    British57602820002
    SCOVILLE, Tom
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    Director
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    New Oxford House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish147690430001
    SHERBURN, Ian
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    England
    Director
    11-15 Brayford Wharf East
    LN5 7AY Lincoln
    The Maltings
    England
    United KingdomBritish73045470001
    SQUIRRELL, Michael James
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Director
    c/o Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    United KingdomBritish154231120001
    WEST, Jonathan Paul, Sol
    26 Yews Lane
    Laceby
    DN37 7SU Grimsby
    South Humberside
    Director
    26 Yews Lane
    Laceby
    DN37 7SU Grimsby
    South Humberside
    British68164560001
    WRIGHT, Amy
    New Oxford House PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    Lincolnshire
    Director
    New Oxford House PO BOX 16
    Town Hall Square
    DN31 1HE Grimsby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish165977090001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WILCHAP NOMINEES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wilkin Chapman Llp
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    06 abr 2016
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Liability Partnership
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalLimited Liability Partnerships Act 2000
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registroOc343261
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0