GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03511464 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
- Administración de la propiedad de los residentes (98000) / Actividades de los hogares como empleadores; actividades de producción de bienes y servicios no diferenciadas de los hogares para uso propio
¿Dónde se encuentra GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Dirección de la sede social | Unit 6 Pickwick Park Park Lane SN13 0HN Corsham England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 16 feb 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 02 mar 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 16 feb 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Office F1 Unit 23 Leafield Industrial Estate Corsham SN13 9RS England a Unit 6 Pickwick Park Park Lane Corsham SN13 0HN el 18 feb 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Spg Property Limited como secretario el 01 nov 2023 | 2 páginas | AP04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Belmont Bath BA1 5DZ England a Office F1 Unit 23 Leafield Industrial Estate Corsham SN13 9RS el 05 nov 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2022 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Elspeth Joan Alexander como director el 30 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2023 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2021 | 3 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Peter Curtis Smith como director el 31 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Margaret Marian Wiggins como director el 25 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Nigel Mark Chandler como director el 25 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Rachel Pearce como director el 11 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Paul Francis como director el 11 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Colin Ross Mackay como director el 11 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Ian Leslie Horsfield como director el 26 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2022 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2019 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2020 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Margaret Marian Wiggins como director el 20 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Margaret Marian Wiggins como director el 19 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2018 | 2 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG PROPERTY LIMITED | Secretario corporativo | Unit 23 Leafield Industrial Estate SN13 9RS Corsham Office F1 England |
| 300010070001 | ||||||||||
FRANCIS, Paul | Director | Park Lane SN13 0HN Corsham Unit 6 Pickwick Park England | England | British | Retired | 297876470001 | ||||||||
GODFREY, Michael Terrance | Director | Greenland Mills BA15 1BL Bradford-On-Avon 49 England | England | British | Estate Agent | 196560530002 | ||||||||
JOHNSON, Monica Ana | Director | Park Lane SN13 0HN Corsham Unit 6 Pickwick Park England | England | British | Retired | 261258130001 | ||||||||
MACKAY, Colin Ross | Director | Park Lane SN13 0HN Corsham Unit 6 Pickwick Park England | England | British | Retired | 297876160001 | ||||||||
NUTT, Mary Isobel | Director | Park Lane SN13 0HN Corsham Unit 6 Pickwick Park England | England | British | Retired | 261258830001 | ||||||||
PEARCE, Rachel | Director | Park Lane SN13 0HN Corsham Unit 6 Pickwick Park England | England | British | Lawyer | 297876950001 | ||||||||
SMITH, Peter Curtis | Director | Park Lane SN13 0HN Corsham Unit 6 Pickwick Park England | England | British | Retired | 175496180001 | ||||||||
HUNT, Derrick John | Secretario | 43 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | British | Contracts Manager | 95994470001 | |||||||||
O'SULLIVAN, Daniel John | Secretario | Two Hoots Yester Park BR7 5DG Chislehurst Kent | British | Chartered Accountant | 1630610002 | |||||||||
SALTER, Jonathan David | Secretario | 29 Blackbrook Lane BR2 8AU Bickley Kent | British | 89423990001 | ||||||||||
SIMMONS, Kay Vivienne | Secretario | 6 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | British | Retired | 222824140001 | |||||||||
VELLEMAN, Deborah Mary | Secretario | Gay Street BA1 2PH Bath 6 Banes | British | 149056920001 | ||||||||||
WOOD, Michael | Secretario | 11 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | British | Retired | 91464800001 | |||||||||
HML COMPANY SECRETARIAL SERVICES LTD | Secretario corporativo | TW9 1BP Richmond 9-11 The Quadrant Surrey United Kingdom |
| 158243630001 | ||||||||||
LABYRINTH PROPERTIES LIMITED | Secretario corporativo | 2 The Gardens Office Village PO16 8SS Fareham Hampshire | 98078020001 | |||||||||||
ALEXANDER, Elspeth Joan | Director | Belmont BA1 5DZ Bath 1 England | England | British | Retired | 261258550001 | ||||||||
BEAUMONT, Andrew Philip | Director | 1 Greenland Mills Bridge Street BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | British | It Project Manager | 66018880002 | |||||||||
CARPENTER, David George | Director | 3 Kings Road House 2 Kings Road SL4 2AG Windsor Berkshire | British | Surveyor | 25931250002 | |||||||||
CHANDLER, Nigel Mark | Director | Belmont BA1 5DZ Bath 1 England | England | British | Sales & Marketing | 261257530001 | ||||||||
D'ARCY, Christine Barbara | Director | 60 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon The Mill House Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | Retired | 91465740002 | ||||||||
FARTHING, Stuart James | Director | 53 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | British | Director | 95890810001 | |||||||||
HORSFIELD, Ian Leslie | Director | Belmont BA1 5DZ Bath 1 England | England | British | Retired | 261257960001 | ||||||||
HUNT, Derrick John | Director | 43 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | England | British | Contracts Manager | 95994470001 | ||||||||
JOHNSTON, David Lawrence | Director | 8 Greenland Mills Bridge Street BA15 1BL Bradford On Avon Weirside Mill United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 231680490001 | ||||||||
JONES, Martin Roy | Director | 19 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | United Kingdom | British | Retired | 72425270001 | ||||||||
LLOYD, Stephen John | Director | Belmont BA1 5DZ Bath 1 England | England | British | Retired | 260265380001 | ||||||||
O'SULLIVAN, Daniel John | Director | Two Hoots Yester Park BR7 5DG Chislehurst Kent | British | Chartered Accountant | 1630610002 | |||||||||
PAPIERZ, Karl | Director | 40 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | British | Building Surveyor | 108229150001 | |||||||||
RAMSDALE, Susan Laura | Director | Greenland Mills BA15 1BL Bradford-On-Avon 15 Wiltshire | Uk | British | Pharmacist | 163707720001 | ||||||||
RANN, William Paul | Director | 45 Dove Park Chorleywood WD3 5NY Rickmansworth Hertfordshire | British | Chartered Surveyor | 7431570001 | |||||||||
ROCHE, Mary Cynthia | Director | 23 Upper Mill Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | United Kingdom | British | Retired | 99380390001 | ||||||||
SHEPPARD, Anne, Dr | Director | Greenland Mills BA15 1BL Bradford-On-Avon 16 England | England | British | Retired Psychologist | 222703400001 | ||||||||
SIMMONS, Kay Vivienne | Director | Greenland Mills BA15 1BL Bradford-On-Avon 6 England | United Kingdom | British | Retired Purchasing Procurement | 222824140001 | ||||||||
SIMMONS, Kay Vivienne | Director | 6 Greenland Mills BA15 1BL Bradford On Avon Wiltshire | United Kingdom | British | Retired | 222824140001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GREENLAND MILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
16 feb 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0