TINGLOBAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTINGLOBAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03516437
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TINGLOBAL LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra TINGLOBAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bankside Park, 15 Love Lane
    Cirencester
    GL7 1YG Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TINGLOBAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLOBAL COMPUTER HOLDINGS LIMITED22 may 200222 may 2002
    APEX COMPUTERS HOLDINGS LIMITED 06 jul 199806 jul 1998
    OVAL (1291) LIMITED24 feb 199824 feb 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TINGLOBAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TINGLOBAL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TINGLOBAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    L53TW1UJ

    Cancelación total de la carga 035164370006

    1 páginasMR04
    X54GMAE3

    Cancelación total de la carga 035164370007

    1 páginasMR04
    X54GMAVL

    Déclaration annuelle établie au 25 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 mar 2016

    Estado de capital el 24 mar 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X53FW0MJ

    Nombramiento de David Kidger como secretario el 26 feb 2016

    2 páginasAP03
    X51ORZP5

    Cese del nombramiento de John Royford Birt como secretario el 26 feb 2016

    1 páginasTM02
    X51ORZ83

    legacy

    1 páginasSH20
    S511BQPL

    Estado de capital el 18 feb 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19
    A510M8HF

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    S511BQRC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share prem a/c and apital redemption reserve cancelled 18/02/2016
    RES13

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD
    A4ZVBREJ

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04
    X4ZFKB6J

    Registro de la carga 035164370007, creada el 13 oct 2015

    32 páginasMR01
    X4I4GI7C

    Registro de la carga 035164370006, creada el 05 oct 2015

    26 páginasMR01
    X4HWHGS7

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04
    X4F82514

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04
    X4F82656

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA
    A46JX85C

    Nombramiento de Mrs Angela Jane Wilkinson como director el 02 mar 2015

    2 páginasAP01
    X432F4E7

    Cese del nombramiento de David James Gutteridge como director el 27 feb 2015

    1 páginasTM01
    X432F3U9

    Déclaration annuelle établie au 25 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 feb 2015

    Estado de capital el 25 feb 2015

    • Capital: GBP 29,676
    SH01
    X41Z1N2Z

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    14 páginasAA
    A3H92WIY

    Nombramiento de John Royford Birt como secretario el 25 jul 2014

    2 páginasAP03
    X3D9IFAP

    Cese del nombramiento de David James Gutteridge como secretario el 25 jul 2014

    1 páginasTM02
    X3D9IF8X

    ¿Quiénes son los directivos de TINGLOBAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KIDGER, David
    15 Love Lane
    GL7 1YG Cirencester
    Bankside Park
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secretario
    15 Love Lane
    GL7 1YG Cirencester
    Bankside Park
    Gloucestershire
    United Kingdom
    205567670001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    JORDAN, Matthew George
    Oakley Road
    GL52 6PA Battledown
    May House
    Cheltenham
    Director
    Oakley Road
    GL52 6PA Battledown
    May House
    Cheltenham
    United KingdomBritishSales Director75095880003
    WILKINSON, Angela Jane
    15 Love Lane
    GL7 1YG Cirencester
    Bankside Park
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    15 Love Lane
    GL7 1YG Cirencester
    Bankside Park
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of It Services86017570001
    BIRT, John Royford
    15 Love Lane
    GL7 1YG Cirencester
    Bankside Park
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secretario
    15 Love Lane
    GL7 1YG Cirencester
    Bankside Park
    Gloucestershire
    United Kingdom
    189815660001
    BULLEY, Duncan
    6 Westfield Park
    Redland
    BS6 6LT Bristol
    Secretario
    6 Westfield Park
    Redland
    BS6 6LT Bristol
    British58884530005
    GUTTERIDGE, David James
    93 Oakhurst Road
    SY11 1BL Oswestry
    Salop
    Secretario
    93 Oakhurst Road
    SY11 1BL Oswestry
    Salop
    BritishChairman39822940001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secretario designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    BULLEY, Duncan
    6 Westfield Park
    Redland
    BS6 6LT Bristol
    Director
    6 Westfield Park
    Redland
    BS6 6LT Bristol
    EnglandBritishChartered Accountant58884530005
    CLEAVER, Garry Wayne
    42 Bowling Green Lane
    GL7 2DY Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    42 Bowling Green Lane
    GL7 2DY Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director63081320004
    ELSDEN, John Kirk Saunderson
    Bucks Head
    Hammerpond Road
    RH13 6PF Horsham
    West Sussex
    Director
    Bucks Head
    Hammerpond Road
    RH13 6PF Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Chairman And Director7584640001
    GUTTERIDGE, David James
    93 Oakhurst Road
    SY11 1BL Oswestry
    Salop
    Director
    93 Oakhurst Road
    SY11 1BL Oswestry
    Salop
    United KingdomBritishAccountant39822940001
    HADDRELL, Rodney Raymond Melford
    Fiarfield
    Shutford
    OX15 6HB Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Fiarfield
    Shutford
    OX15 6HB Banbury
    Oxfordshire
    BritishManaging Director37527550001
    HENLY, Graham Paul
    7 The Spinney
    GL7 3RZ Lechlade
    Wiltshire
    Director
    7 The Spinney
    GL7 3RZ Lechlade
    Wiltshire
    BritishComputer Sales26957830002
    KING, Nicholas Paul
    Gemini Cottage
    Box
    GL6 9HW Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Gemini Cottage
    Box
    GL6 9HW Stroud
    Gloucestershire
    BritishComputer Sales106156940002
    ROSHIER, Christopher Edward
    37 Imber Park Road
    KT10 8JB Esher
    Surrey
    Director
    37 Imber Park Road
    KT10 8JB Esher
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director10253560002
    STEWART, Hugh John Patrick
    Manor Farm House
    Abbots Ann
    SP11 7BB Andover
    Hampshire
    Director
    Manor Farm House
    Abbots Ann
    SP11 7BB Andover
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector4144970002
    WOODING, Graham Peter Charles
    Priory Farm
    Reeds Drive, Woolavington
    TA7 8DR Bridgwater
    Somerset
    Director
    Priory Farm
    Reeds Drive, Woolavington
    TA7 8DR Bridgwater
    Somerset
    BritishCompany Director77761110001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Director designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Director designado corporativo
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    ¿Tiene TINGLOBAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 13 oct 2015
    Entregado el 16 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 05 oct 2015
    Entregado el 13 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 28 jun 2011
    Entregado el 06 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Nvm Private Equity Limited
    Transacciones
    • 06 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 04 sept 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 28 jun 2011
    Entregado el 02 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or any of them or to the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • David James Gutteridge
    Transacciones
    • 02 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 04 sept 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 abr 2010
    Entregado el 24 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 24 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 26 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 abr 2008
    Entregado el 12 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 29 may 1998
    Entregado el 03 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 14 ene 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0