CARDPOINT SERVICES LIMITED

CARDPOINT SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARDPOINT SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03516589
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o CARDTRONICS UK LIMITED
    Building 4, 1st Floor Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARDPOINT SERVICES TRADING AS CASHZONE LIMITED19 feb 200919 feb 2009
    CARDPOINT SERVICES LIMITED23 oct 200823 oct 2008
    MONEYBOX CORPORATION LIMITED17 ene 200017 ene 2000
    MONEY BOX CORPORATION LIMITED25 feb 199825 feb 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Michael Edward Keller como director el 25 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Christopher Brewster como director el 25 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Edward Keller como secretario el 25 jun 2015

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 25 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 mar 2015

    Estado de capital el 03 mar 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Squire Sanders (Uk) Llp Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR England a C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 páginasAD03

    Nombramiento de Jana Hile como director el 15 ago 2014

    2 páginasAP01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 27 nov 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Jeremy David Kraft como director el 30 sept 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    19 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de , Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House, 148 Edmund Street, Birmingham, B3 2JR el 16 jun 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 25 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 feb 2014

    Estado de capital el 25 feb 2014

    • Capital: GBP 5,769,863.59
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    1 páginasAD04

    Renuncia del auditor

    3 páginasAUD

    Nombramiento de Mr Jeremy David Kraft como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Michael Keller como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de John Christopher Brewster como director

    3 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HILE, Jana
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Director
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    EnglandAustralian192111080001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110396210002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secretario
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HOGAN, Brenda
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Secretario
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Other75975040003
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secretario
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    American105857220002
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Secretario
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Director
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Director
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BREWSTER, John Christopher
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Director
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican181428100001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    Director
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    DINSMORE, Rikki Gavin
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    Director
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    United KingdomBritish137100920001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Director
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Director
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HOLROYD, Richard Norton
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    Director
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    British80220410001
    ISAACS, Vincent
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    Director
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    British38705920001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Director
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican105857220002
    KRAFT, Jeremy David
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    Director
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish71360190003
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Director
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Director
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Director
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MORGAN, Colin John
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Director
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Irish70867300001
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Director
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Director
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    ROBSON, Vincent Martin
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    Director
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    British64602710001
    RYLAND, Stuart Antony
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    Director
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish74367340001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Director
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Director
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Director
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    STIMPSON, Andrew David
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    Director
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    EnglandBritish99393670001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Director
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Tiene CARDPOINT SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A confirmatory security agreement
    Creado el 09 abr 2010
    Entregado el 13 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 13 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 09 ago 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    A second ranking share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Creado el 05 feb 2010
    Entregado el 22 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Existing pledges means the pledges constituted pursuant to the existing share pledge agreement, shares. The pledges include the present and future rights to receive dividends and liquidation proceeds, see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 22 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 09 ago 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    A security agreement
    Creado el 05 dic 2007
    Entregado el 15 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 15 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Share pledge agreement
    Creado el 18 may 2007
    Entregado el 02 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The existing shares and the future shares together with all ancillary rights and claims, dividends payable in relation to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Agent or the Security Trustee). the Royalbank of Scotland the 'Original Pledgees'
    Transacciones
    • 02 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Syndicated debenture
    Creado el 13 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    01. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustees for Thebeneficiaries
    Transacciones
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Creado el 19 dic 2005
    Entregado el 06 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 jul 2005
    Entregado el 15 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 15 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 sept 2004
    Entregado el 09 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 30 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 sept 2004
    Entregado el 03 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 30 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 03 jun 2003
    Entregado el 21 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,100,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    52 authomated teller machines.
    Personas con derecho
    • Abbey National PLC
    Transacciones
    • 21 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of chattels
    Creado el 03 jun 2003
    Entregado el 19 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A number of automated teller machines situated at the locations together with the benefit of a licence to retain the atms at the locations. The benefit of all contracts and agreements relating to the atms. Any goodwill in the atms. The benefit of any insurances in relating to the atms.
    Personas con derecho
    • Abbey National PLC
    Transacciones
    • 19 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0