AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED

AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03517649
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AIG MEDICAL & REHABILITATION LIMITED03 dic 201203 dic 2012
    CHARTIS MEDICAL & REHABILITATION LIMITED30 nov 200930 nov 2009
    AIG MEDICAL & REHABILITATION LIMITED26 mar 199826 mar 1998
    ACCESSDALE LIMITED26 feb 199826 feb 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 mar 2020

    6 páginasLIQ03

    Cese del nombramiento de Fabiola Yvonne Mahoney como director el 31 may 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de confirmación presentada el 26 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de The Aig Building 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB a 15 Canada Square London E14 5GL el 26 abr 2019

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 25 mar 2019

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Cese del nombramiento de Michael Harry Lario como director el 18 sept 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2017

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2016

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario Mr. Andrew George Kane el 27 feb 2017

    1 páginasCH03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 150 Cheapside London EC2V 6ET United Kingdom a The Aig Building 58 Fenchurch Street London EC3M 4AB

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Mr Stephen Agutter como director el 20 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2015

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 mar 2016

    Estado de capital el 01 mar 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Donald C. Hurter como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven Frederick Eckhardt como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Michael Harry Lario como director el 10 dic 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Fabiola Yvonne Mahoney como director el 13 nov 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Tara Laws como director el 25 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Mr. Andrew Kane el 03 ago 2015

    3 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KANE, Andrew George, Mr.
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    199783990001
    AGUTTER, Stephen
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishHead Of Global Property Claims/Commercial217487890001
    HEAP, Michael Conrad
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    EnglandBritishReporting Director187741420001
    ABRAHAM, Stephen Ashley
    Flat 6 Stafford House
    Churchfields
    EN10 7JX Broxbourne
    Hertfordshire
    Secretario
    Flat 6 Stafford House
    Churchfields
    EN10 7JX Broxbourne
    Hertfordshire
    BritishTrainee Solicitor80073350001
    GOLDING, Hilary Margaret Victoria
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Chartis Building
    United Kingdom
    Secretario
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Chartis Building
    United Kingdom
    British148960480001
    HILLERY, Kate
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United Kingdom
    Secretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United Kingdom
    190382760001
    NEWBY, Christopher David Seymour
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United Kingdom
    Secretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United Kingdom
    177814480001
    OGDEN, David
    2 Lynton Close
    WA16 8BH Knutsford
    Cheshire
    Secretario
    2 Lynton Close
    WA16 8BH Knutsford
    Cheshire
    BritishCs38907030001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Secretario designado corporativo
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    ABRAHAM, Stephen Ashley
    Flat 6 Stafford House
    Churchfields
    EN10 7JX Broxbourne
    Hertfordshire
    Director
    Flat 6 Stafford House
    Churchfields
    EN10 7JX Broxbourne
    Hertfordshire
    BritishTrainee Solicitor80073350001
    CAMERON, John
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer176356640001
    CHILDS, Nigel Fitzmaurice
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    Director
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    BritishAccountant47208120003
    ECKHARDT, Steven Frederick
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    United StatesBritishEvp Chief Operating Opfficer Global Commercial Cla56257710003
    ECKHARDT, Steven Frederick
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    Director
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    United StatesBritishReg Claims Insurance Manager56257710003
    GIBLIN, Michael Henry
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    Director
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    United KingdomBritishInsurance Manager50743380003
    GLASER, Daniel Scott
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    Director
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    AmericanCompany Director83937480002
    GORDON, Robert Needham
    Failte 17 Sole Oak Drive
    TN13 1JG Sevenoaks
    Kent
    Director
    Failte 17 Sole Oak Drive
    TN13 1JG Sevenoaks
    Kent
    BritishInsurance Executive44901670002
    HARRIS, Jason Richard
    West Hill Gardens
    GU51 4HU Fleet
    Coppice
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    West Hill Gardens
    GU51 4HU Fleet
    Coppice
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishInsurance Executive151928670001
    HURTER, Donald C.
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    United StatesAmericanSenior Vice President, Global Medical Management S183756580001
    LARIO, Michael Harry
    Pine Street
    22nd Floor
    New Jersey
    80
    New York
    United States
    Director
    Pine Street
    22nd Floor
    New Jersey
    80
    New York
    United States
    United StatesAmericanGlobal Head, Claims Operations203604420001
    LAWS, Tara
    Altyre Road, Surrey
    CR9 2LG Croydon
    2-8
    United Kingdom
    Director
    Altyre Road, Surrey
    CR9 2LG Croydon
    2-8
    United Kingdom
    BritishRehabilitation Service Manager138695470003
    MAHENDRA, Rabiendran
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Accounting Officer172867450001
    MAHONEY, Fabiola Yvonne
    Altyre Road
    CR9 2LG Croydon
    2-8
    England
    Director
    Altyre Road
    CR9 2LG Croydon
    2-8
    England
    EnglandBritishHead Of Medical Management Services203472400001
    MERFIELD, Helen Clare
    Flat 6 80 Elmbourne Road
    Tooting Bec
    SW17 8JH London
    Director
    Flat 6 80 Elmbourne Road
    Tooting Bec
    SW17 8JH London
    BritishNurse Manager47633350001
    MILLER, David Stuart, Mr.
    Avebury Close
    RH125JY Horsham
    6
    England
    England
    Director
    Avebury Close
    RH125JY Horsham
    6
    England
    England
    United KingdomBritishExecutive Director - Head Of Uk Claims173831080001
    SHERMAN, Michael Lee
    5 Tara Park
    Doghurst Lane
    CR5 3PL Chipstead
    Surrey
    Director
    5 Tara Park
    Doghurst Lane
    CR5 3PL Chipstead
    Surrey
    BritishInsurance Manager59609140001
    SMART, Steven David
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Chartis Building
    United Kingdom
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Chartis Building
    United Kingdom
    BritishLegal Counsel27149410003
    SUMMERS, Melanie Jane
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Chartis Building
    United Kingdom
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Chartis Building
    United Kingdom
    BritishDirector84840870001
    WALSH, Nicholas Charles
    Leasam House
    Leasam Lane Playden
    TN31 7UE Rye
    East Sussex
    Director
    Leasam House
    Leasam Lane Playden
    TN31 7UE Rye
    East Sussex
    BritishCompany Director48439060003
    WHITWELL, Michael John
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    Director
    Aig Europe Uk Ltd The Aig Building
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    BritishInsurance Manager53673000003
    WOOD, Simon Vincent
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    Director
    58 Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    EnglandBritishFinance Director131999660002
    WORKMAN, Louise
    59 Hillcrest Road
    BR6 9AQ Orpington
    Kent
    Director
    59 Hillcrest Road
    BR6 9AQ Orpington
    Kent
    BritishSolicitor57555860002
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Director designado corporativo
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    06 abr 2016
    Fenchurch Street
    EC3M 4AB London
    The Aig Building
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalUk
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00521852
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene AIG MEDICAL MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    25 mar 2019Inicio de la liquidación
    06 ago 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0