RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03519669 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
Dirección de la sede social | 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GRANTCHESTER PROPERTIES (CATFORD) LIMITED | 23 feb 1999 | 23 feb 1999 |
GRANTCHESTER PROPERTIES (DUNDEE) LIMITED | 10 mar 1998 | 10 mar 1998 |
INTERCEDE 1302 LIMITED | 02 mar 1998 | 02 mar 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Jackson como director el 23 ago 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew John Jackson el 12 oct 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Michael Hannigan el 12 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Brian Watt el 12 oct 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director David Graham Paine el 08 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Paolo Alonzi el 08 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2011 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 jun 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONZI, Paolo | Secretario | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | Italian | 113225330001 | ||||||
HANNIGAN, Robert Michael | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 81510590004 | ||||
PAINE, David Graham | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | Scotland | British | Company Director | 156455760001 | ||||
WATT, Mark Brian | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 85845500002 | ||||
EVANS, Michael | Secretario | Willowtyne Victoria Road EH41 4DJ Haddington East Lothian | British | 98652120001 | ||||||
HAYDON, Stuart John | Secretario | 156 Woodland Way BR4 9LU West Wickham Kent | British | 3175210001 | ||||||
HOLLOCKS, Ian Michael | Secretario | 22 Fairholme Avenue RM2 5UU Gidea Park Essex | British | 61055270001 | ||||||
REITH, Julie Katharine | Secretario | Flat 3f2 47 Brunswick Road EH7 5PD Edinburgh Midlothian | British | 112039220001 | ||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||
ALFORD, Nicholas Brian Treseder | Director | The Pines North Road HP4 3DX Berkhamsted Hertfordshire | Great Britain | British | Chartered Surveyor | 126970360001 | ||||
ALONZI, Paolo | Director | 20 Rattray Grove EH10 5TL Edinburgh Midlothian | United Kingdom | Italian | Accountant | 113225330001 | ||||
ATKINS, David John | Director | 60 Dukes Wood Drive SL9 7LF Gerrards Cross The Barn Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 144036070001 | ||||
BAKER, Michael John | Director | 18 Seaton Close Lynden Gate Putney Heath SW15 3TJ London | British | Surveyor | 77729120001 | |||||
BYWATER, John Andrew | Director | Craigens Hill Foot Lane Burn Bridge HG3 1NT Harrogate North Yorkshire | England | British | Chartered Surveyor | 71820020003 | ||||
COLE, Peter William Beaumont | Director | Walnut Tree Farm Walnut Tree Road Pirton SG5 3PX Hitchin Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 51145990001 | ||||
EVANS, Christopher Mark Stephen | Director | 12 Criffel Avenue Streatham Hill SW2 4AZ London | England | British | Chartered Surveyor | 71333340001 | ||||
HARDIE, Nicholas Alan Scott | Director | Albert Square SW8 1BS London 21 | England | British | Financial Controller | 56627250001 | ||||
HARRIS, Iain Farlane Sim | Director | 1 Red Lion Cottages WD25 8BB Aldenham Hertfordshire | England | British | Accountant | 56363000001 | ||||
HEWSON, Andrew Nicholas | Director | Abesters Fernden Lane Blackdown GU27 3BS Haslemere Surrey | British | Company Director | 8607090005 | |||||
HUBERMAN, Paul Laurence | Director | 15 Wildwood Road Hampstead Garden Suburb NW11 6UL London | England | British | Director | 3470530003 | ||||
JACKSON, Andrew John | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 83130180001 | ||||
MCGUIRE, Martin Anton | Director | 4 Gilmour Road EH16 5NF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Surveyor | 46513600001 | ||||
REEVES, Barbara | Director | Flat 2 24 Bracknell Gardens NW3 7ED London | United Kingdom | British | Company Secretary | 75639030006 | ||||
RICH, Michael William | Director | Hillfield Gorse Hill, Farningham DA4 0JU Dartford Kent | British | Solicitor | 70341190001 | |||||
WALTON, Timothy Paul | Director | Ivy House Church Row Meole Brace SY3 9EY Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Director | 59971310002 | ||||
WHIGHT, Paul James | Director | 24d Thameside RG9 2LJ Henley-On-Thames Oxfordshire | British | Director | 110745030002 | |||||
WRIGHT, Geoffrey Harcroft | Director | Michaelmas House 4 The Riddings CR3 6DW Caterham Surrey | British | Building Surveyor | 8585700001 |
¿Tiene RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 08 may 2000 Entregado el 17 may 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of (I) the chargor and (ii) gel to any of the finance parties under or pursuant to the financing documents (all terms as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 12 abr 2000 Entregado el 17 abr 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Breve descripción For property details see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0