RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED

RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03519669
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GRANTCHESTER PROPERTIES (CATFORD) LIMITED23 feb 199923 feb 1999
    GRANTCHESTER PROPERTIES (DUNDEE) LIMITED10 mar 199810 mar 1998
    INTERCEDE 1302 LIMITED02 mar 199802 mar 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew John Jackson como director el 23 ago 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jun 2016

    Estado de capital el 29 jun 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Andrew John Jackson el 12 oct 2015

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Robert Michael Hannigan el 12 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Mark Brian Watt el 12 oct 2015

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director David Graham Paine el 08 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Paolo Alonzi el 08 oct 2015

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    12 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB

    1 páginasAD04

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 jul 2015

    Estado de capital el 14 jul 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jul 2014

    Estado de capital el 28 jul 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 jul 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 jul 2013

    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    ¿Quiénes son los directivos de RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALONZI, Paolo
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Secretario
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Italian113225330001
    HANNIGAN, Robert Michael
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Director
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director81510590004
    PAINE, David Graham
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Director
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director156455760001
    WATT, Mark Brian
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Director
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director85845500002
    EVANS, Michael
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    Secretario
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    British98652120001
    HAYDON, Stuart John
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Secretario
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British3175210001
    HOLLOCKS, Ian Michael
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    Secretario
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    British61055270001
    REITH, Julie Katharine
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    British112039220001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    ALFORD, Nicholas Brian Treseder
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Great BritainBritishChartered Surveyor126970360001
    ALONZI, Paolo
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    Director
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomItalianAccountant113225330001
    ATKINS, David John
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    Director
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor144036070001
    BAKER, Michael John
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    Director
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    BritishSurveyor77729120001
    BYWATER, John Andrew
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor71820020003
    COLE, Peter William Beaumont
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor51145990001
    EVANS, Christopher Mark Stephen
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    Director
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    EnglandBritishChartered Surveyor71333340001
    HARDIE, Nicholas Alan Scott
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    Director
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    EnglandBritishFinancial Controller56627250001
    HARRIS, Iain Farlane Sim
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    Director
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant56363000001
    HEWSON, Andrew Nicholas
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Director
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    BritishCompany Director8607090005
    HUBERMAN, Paul Laurence
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    Director
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    EnglandBritishDirector3470530003
    JACKSON, Andrew John
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Director
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director83130180001
    MCGUIRE, Martin Anton
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSurveyor46513600001
    REEVES, Barbara
    Flat 2 24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    Director
    Flat 2 24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    United KingdomBritishCompany Secretary75639030006
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Director
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    BritishSolicitor70341190001
    WALTON, Timothy Paul
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector59971310002
    WHIGHT, Paul James
    24d Thameside
    RG9 2LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Director
    24d Thameside
    RG9 2LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector110745030002
    WRIGHT, Geoffrey Harcroft
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    Director
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    BritishBuilding Surveyor8585700001

    ¿Tiene RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 08 may 2000
    Entregado el 17 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of (I) the chargor and (ii) gel to any of the finance parties under or pursuant to the financing documents (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Ag Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank (London Branch) (the "Securitytrustee", Which Expression Shall Include All Successor Agents Appointed from Time to Time)
    Transacciones
    • 17 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 25 jun 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 12 abr 2000
    Entregado el 17 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Breve descripción
    For property details see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westdeutsche Immobilienbank (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 17 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 31 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0